FIRST OIL EXPRO LIMITED

FIRST OIL EXPRO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIRST OIL EXPRO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01021486
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    • Estrazione di petrolio greggio (06100) / Attività estrattive

    Dove si trova FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TUSKAR EXPRO LIMITED15 nov 199515 nov 1995
    SHENANDOAH EXPRO LIMITED06 giu 198806 giu 1988
    HIGHLAND EXPLORATION LTD17 lug 198617 lug 1986
    LOCHIEL EXPLORATION (U.K.) LIMITED18 ago 197118 ago 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    29 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    7 pagineAM16

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Cessazione della carica di Martin Ian Suttie come amministratore in data 31 mag 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven David Bowyer come amministratore in data 30 set 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Brian Ross Cameron come amministratore in data 02 giu 2016

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 gen 2017

    36 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 13

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 010214860016

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 14

    5 pagineMR05

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 ago 2016

    30 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    42 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    12 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a C/O Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 09 mar 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da 21 Regatta House 32 Twickenham Road Teddington Middlesex TW11 8AZ a C/O Cms Cameron Mckenna Llp Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF in data 21 gen 2016

    1 pagineAD01

    Ordinanza giudiziaria

    S1096 Court Order to Rectify
    3 pagineOC

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 010214860016

    5 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di FIRST OIL EXPRO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SUTTIE, Ian Alexander, Mr.
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    ScotlandBritishCompany Director52794240001
    CARROLL, Stephen
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Segretario
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Secretary36244540001
    GEORGE, Steven Richard
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    Segretario
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    OtherChartered Accountant126930530001
    GRANT, Stephen
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Segretario
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant139292040001
    MAHONY, Patrick Gerald
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Segretario
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Irish173542290001
    MEARNS, Steven Macdonald
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115242820001
    SUTTIE, Martin Ian
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Segretario
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    155292180001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BOARDMAN, Angela
    180 Anderson Drive
    AB15 6DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    180 Anderson Drive
    AB15 6DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishChartered Accountant70821770001
    BOWYER, Steven David
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    United KingdomBritishManaging Director128424830001
    BROWN, Emmet Kevin
    45 Lower Dodder Road
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    45 Lower Dodder Road
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishGeologist126870510001
    CAMERON, Brian Ross
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    ScotlandBritishExploration Director152775280001
    CARROLL, Stephen
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    6 Merrion Crescent
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant36244540001
    COWIE, John
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishPetroleum Engineer132901500001
    FORBES, Graham Andrew
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishChartered Accountant83876980001
    GEORGE, Steven Richard
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishChartered Accountant161491510001
    GRANT, Donald Alexander
    Brentwood, 16 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AB Aberdeen
    Amministratore
    Brentwood, 16 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AB Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director60152030001
    IRELAND, Stephen Richard
    5 Stanley Road
    SW14 7EB East Sheen
    London
    Amministratore
    5 Stanley Road
    SW14 7EB East Sheen
    London
    BritishCompany Director76281980001
    JONES, Thomas Axel
    20 Craigmarn Road
    Portlethen
    AB12 4QR Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    20 Craigmarn Road
    Portlethen
    AB12 4QR Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director63516810001
    LANDER, John Hugh Russell
    Camelot
    26 The Island
    KT7 0SH Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    Camelot
    26 The Island
    KT7 0SH Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director1126370003
    MAHONY, Patrick Gerald
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    103 Rath Farnham Wood
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant173542290001
    MCGILLGAN, John
    10 Hill Court Park
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    10 Hill Court Park
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    BritishCompany Director32218590001
    MCGREGOR, Duncan Alexander
    New Town Lodge Stud
    IRISH Kildare
    Ireland
    Amministratore
    New Town Lodge Stud
    IRISH Kildare
    Ireland
    BritishConsultant17181720001
    SUTTIE, Martin Ian
    c/o First Oil
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    Amministratore
    c/o First Oil
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    ScotlandBritishBusiness Development Director191591080001
    TRAYNOR, Frank Joseph
    34 Rathdown Park
    IRISH Terenure
    Dublin
    Ireland
    Amministratore
    34 Rathdown Park
    IRISH Terenure
    Dublin
    Ireland
    IrishEngineer36244370001
    WALPOLE, Ivan William
    170 Clonkeen Road
    IRISH Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    170 Clonkeen Road
    IRISH Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant41158150001

    FIRST OIL EXPRO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 apr 2014
    Consegnato il 25 apr 2014
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 25 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 lug 2013
    Consegnato il 25 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ian Alexander Suttie
    Transazioni
    • 25 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 mag 2013
    Consegnato il 22 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas in Its Capacity as Security Trustee for Itself and on Behalf of the Finance Parties
    Transazioni
    • 22 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 ago 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 dic 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Deed of amendment to debenture
    Creato il 23 nov 2011
    Consegnato il 01 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian Alexander Suttie
    Transazioni
    • 01 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian Alexander Suttie
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 dic 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 ago 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 dic 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Deed of pledge of receivables and rights also dated 13 july 2007 and
    Creato il 16 lug 2007
    Consegnato il 20 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first priority right of non-disclosed pledge on the present rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and for and Onbehalf of the Finance Parties
    Transazioni
    • 20 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Shares pledge also dated 06 july 2007 and
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 20 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title interest and benefit in and to the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and for and Onbehalf of the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over accounts
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 19 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged accounts and the charged funds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for Itself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 19 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 ott 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee Foritself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over accounts
    Creato il 19 ott 2004
    Consegnato il 29 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged accounts and the charged funds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee Foritself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 29 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Cash deposit pledge
    Creato il 14 feb 2003
    Consegnato il 26 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the present and future rights,titles and benefit of the company whatsoever in the charged account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Cash deposit pledge
    Creato il 14 feb 2003
    Consegnato il 26 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the present and future rights,titles and benefit of the company whatsoever in the charged account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 07 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1984
    Consegnato il 29 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 8.3.84 and the charge
    Brevi particolari
    All right, title, interest and benefit of lochiel in (I) the lochiel interest (ii) all lochiel petroleum (iii) all book & other debts, revenues & claims (see doc M36 for details).
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation
    Creato il 19 nov 1982
    Consegnato il 09 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the credit agreement dated 21.8.79 & deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    The whole right, title interest & benefit of the company in & to the subjected rights as defined in the said lochiel partial scottish retrocession & assignation) (for full details see doc m 33).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transazioni
    • 09 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Deed of confirmation
    Creato il 29 gen 1982
    Consegnato il 16 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreement dated 21 aug 1979 as amended by the amendment agreements
    Brevi particolari
    All the property mortgaged or charged by or pursuant to the said lochiel english debenture lochiel scottish assignation and lochiel floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    An assignation
    Creato il 29 gen 1982
    Consegnato il 10 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreement dated 21 august 1979 as amended by the amendment agreements
    Brevi particolari
    All the right title interest and benefit of lochiel interest as defined and referred to in the said lochiel second scottish assignation (see doc 31).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1982Registrazione di un'ipoteca

    FIRST OIL EXPRO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 feb 2016Inizio dell'amministrazione
    30 gen 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praticante
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Richard James Beard
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    James Robert Tucker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0