JJB SPORTS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJJB SPORTS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01024895
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JJB SPORTS PLC?

    • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzature da pesca, articoli da campeggio, barche e biciclette (47640) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati (47710) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di calzature in negozi specializzati (47721) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di articoli in pelle in negozi specializzati (47722) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova JJB SPORTS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di JJB SPORTS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JJB SPORTS PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per JJB SPORTS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2015

    25 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 set 2015

    25 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2015

    24 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 gen 2014

    24 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE in data 29 gen 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE in data 29 gen 2015

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2014

    27 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 gen 2014

    25 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2013

    27 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Chi sono gli amministratori di JJB SPORTS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Segretario
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161503180001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish55757700003
    BERNSTEIN, Richard Philip
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    EnglandBritish3324230004
    CHRISTENSEN, Lawrence Richard
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish171869320001
    CORLISS, Robert James
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    UsaAmerican170571310001
    MCTIGHE, Michael
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish156709120001
    PINSENT, Matthew Clive, Sir
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish148640400001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Segretario
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Segretario
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Segretario
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Segretario
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    British77961690001
    BEEVER, David Milton Maxwell
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    Amministratore
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    United KingdomBritish35274610001
    BENZIE, Alan Athol Emslie
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    Amministratore
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    EnglandBritish83412170001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Amministratore
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    CLARE, John Charles
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    EnglandBritish16875650001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Amministratore
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Amministratore
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FOSTER, George William
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish106832100001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Amministratore
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, David Charles, Sir
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish11515940001
    JONES, Keith John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish161521440001
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Amministratore
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LANE SMITH, Roger
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    Amministratore
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    United KingdomBritish109062130002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Amministratore
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    RIGBY, Mary
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    British28471030002
    RONNIE, Christopher
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandScottish79360390002
    SHARPE, Duncan James
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    British13873080002
    THOMAS, Andrew Gerald
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    British2024880001
    TRANTER, Colin Albert
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    Amministratore
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritish138755910001
    WAUDBY, Roy
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    Amministratore
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    British8652040001
    WHELAN, David
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish4527330001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    Amministratore
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    EnglandBritish135547730001

    JJB SPORTS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 apr 2012
    Consegnato il 04 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land on the south west side of challenge way, wigan, t/no: GM718947; f/h land and buildings lying to the south of challenge way, wigan; and f/h land and buildings lying on the south side of challenge way, wigan, t/no:GM811303 (for details of all other property charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 04 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 giu 2009
    Consegnato il 17 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    A charge over an account
    Creato il 03 giu 2009
    Consegnato il 12 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee charged by way of first fixed charge all of the rights, title and interest from time totime in and to each charged asset see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account charge
    Creato il 17 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 2008
    Consegnato il 11 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 11 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2008
    Consegnato il 02 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2008
    Consegnato il 29 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611079 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter, James Cairns Mcmahon and Robert Mcdougall Glennie, as Trustees of the Tbhunter Trust for Children
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611061 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611053 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611020 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611038 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611046 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter, Marion Agnes Hunter and Robert Mcdougall Glennieas Trustees of the Tb Hunter's Charitable Trust
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and Robert Mcdougall Glennie as Trustees of the Tb Hunter Trust Forchildren
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security deposit agreement
    Creato il 11 set 1998
    Consegnato il 16 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity and under the security deposit agreement
    Brevi particolari
    The deposit and all rights and benefits accruing or arising in connection therewith. Deposit means the amount credited to the account from time to time in sterling (initially being the sum of £170,478,001) including all interest credited thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 16 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 nov 1993
    Consegnato il 19 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of leopold street, wigan, greater manchester t/no gm 347289.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings west of wallgate wigan gtr manchester t/n GM167976.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1992
    Consegnato il 23 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    54 and 56 wallgate wigan greater manchester title no: GM150634.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 22 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36 & 38 whitechapel & 25-31 (odd) williamson street liverpool merseyside t/no ms 332264.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JJB SPORTS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 apr 2009Data della riunione per approvare il CVA
    16 giu 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    22 mar 2011Data della riunione per approvare il CVA
    01 ott 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    3
    DataTipo
    01 ott 2012Inizio dell'amministrazione
    25 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0