SSL PRODUCTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SSL PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01026788 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SSL PRODUCTS LIMITED?
- Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SSL PRODUCTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 103-105 Bath Road SL1 3UH Slough Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SSL PRODUCTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SSL HOLDINGS LIMITED | 08 set 1999 | 08 set 1999 |
| PROTECTOFOAM PRODUCTS LIMITED | 13 ott 1992 | 13 ott 1992 |
| PAN MED LIMITED | 17 gen 1990 | 17 gen 1990 |
| PROTECTOFOAM PRODUCTS LIMITED | 08 ott 1971 | 08 ott 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SSL PRODUCTS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SSL PRODUCTS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SSL PRODUCTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Stephen Christopher Andrew Pickstone come amministratore in data 08 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Nomina di Mr James Douglas Colin Mansell come amministratore in data 08 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2024 | 21 pagine | AA | ||||||
legacy | 236 pagine | PARENT_ACC | ||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Cessazione della carica di Richard Mark Greensmith come amministratore in data 21 lug 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Nomina di Gareth Robert Williams come amministratore in data 21 lug 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Seconda presentazione per la nomina di Sally Kenward come segretario | 5 pagine | RP04AP03 | ||||||
Cessazione della carica di James Edward Hodges come segretario in data 08 feb 2025 | 1 pagine | TM02 | ||||||
Nomina di Mrs Sally Kenward come segretario in data 08 mar 2025 | 3 pagine | AP03 | ||||||
| ||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023 | 20 pagine | AA | ||||||
legacy | 235 pagine | PARENT_ACC | ||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Nomina di Mr James Edward Hodges come amministratore in data 14 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Timothy John Martel come amministratore in data 14 feb 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 25 pagine | AA | ||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 27 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen Christopher Andrew Pickstone il 08 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||
Nomina di Stephen Christopher Andrew Pickstone come amministratore in data 22 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Chi sono gli amministratori di SSL PRODUCTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENWARD, Sally | Segretario | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire England | 333365700001 | |||||||
| HODGES, James Edward | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | England | British | 277919780001 | |||||
| MANSELL, James Douglas Colin | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 337791230002 | |||||
| WILLIAMS, Gareth Robert | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 277947570001 | |||||
| BUXTON SMITH, Maria Rita | Segretario | 35 New Bridge Street EC4V 6BW Lond0n Ssl International Plc | British | 108679560001 | ||||||
| GOULD, John Roger Beresford | Segretario | 4 The Park Grasscroft OL4 4ES Oldham Lancashire | British | 14374320001 | ||||||
| HODGES, James Edward | Segretario | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | 270848260001 | |||||||
| JOWETT, Jonathan David | Segretario | 43 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | British | 103825760001 | ||||||
| LOGAN, Christine Anne-Marie | Segretario | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | 193710370001 | |||||||
| MANNION, Antony Clive Patrick | Segretario | Castle Farm TN32 5JU Mountfield East Sussex | British | 100717090002 | ||||||
| RICHARDSON, Elizabeth Anne | Segretario | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | British | 155634480001 | ||||||
| ANDERSEN, Henning Lang | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 171037300001 | |||||
| BUCHAN, Brian John | Amministratore | Manor Farmhouse Fyfield OX13 5LR Abingdon Oxfordshire | England | British | 75146390001 | |||||
| BUXTON-SMITH, Maria Rita, Dr | Amministratore | 35 New Bridge Street EC4V 6BW London Ssl International Plc Bucks | British | 132247000001 | ||||||
| CAIZZONE, Salvatore | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | Italian | 162392060001 | |||||
| CATER, Iain Charles Douglas | Amministratore | The Orchard The Avenue Hale WA15 0LX Altrincham Cheshire | British | 14374310003 | ||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris, Dr | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 178833710001 | |||||
| COLLYER, Graham John | Amministratore | Bowden Head Farmhouse Bowden Lane Chapel En Le Frith SK23 0QP Stockport Derbyshire | England | British | 41561980002 | |||||
| DAVIES, Candida Jane | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 171034990001 | |||||
| DAVIS, Shaun Kevin | Amministratore | 35 New Bridge Street EC4V 6BW London Ssl International Plc | Gb-Eng | United Kingdom | 34817680002 | |||||
| DAWAR, Manish | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | Indian | 139802400002 | |||||
| DWYER, Robert Charles | Amministratore | Little Birches 22 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | England | British | 121903390001 | |||||
| EDWARDS, Simon Jeremy | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 66138060002 | |||||
| GEORGE, Dieno | Amministratore | Holsworthy Farm Boots Green Allostock WA16 9NU Knutsford Cheshire | British | 78647320003 | ||||||
| GOULD, John Roger Beresford | Amministratore | 4 The Park Grasscroft OL4 4ES Oldham Lancashire | United Kingdom | British | 14374320001 | |||||
| GREENSMITH, Richard Mark | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 205672130001 | |||||
| HUMPHREYS, Roger Owen | Amministratore | Squirrels Chase 23 Park Road Disley SK12 2NA Stockport Cheshire | British | 17695720002 | ||||||
| JOWETT, Jonathan David | Amministratore | 43 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | United Kingdom | British | 103825760001 | |||||
| KEELEY, Martin Spencer | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | British | 136190480001 | |||||
| MANNION, Antony Clive Patrick | Amministratore | 35 New Bridge Street EC4V 6BW London Ssl International Plc | United Kingdom | British | 100717090003 | |||||
| MARTEL, Timothy John | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 270646150001 | |||||
| MORAN, Mark | Amministratore | 35 New Bridge Street EC4V 6BW London Ssl International Plc England | United Kingdom | British | 60066000007 | |||||
| MORDAN, William Richard | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire | United Kingdom | American | 155492700001 | |||||
| PEACH, Alasdair James | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 249111940001 | |||||
| PICKSTONE, Stephen Christopher Andrew | Amministratore | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 291287930002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SSL PRODUCTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssl International Plc | 10 dic 2020 | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sonet Investments Limited | 06 apr 2016 | Bath Road SL1 3UH Slough 103-105 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0