BAKER STREET GARAGE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BAKER STREET GARAGE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01027854 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BAKER STREET GARAGE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BAKER STREET GARAGE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Birchwood Dell Bessacarr DN4 6SY Doncaster South Yorkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BAKER STREET GARAGE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BAKER STREET GARAGE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2018, non revisionato | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Monckton Court South Newbald Road North Newbald York YO43 4RW a 1 Birchwood Dell Bessacarr Doncaster South Yorkshire DN4 6SY in data 06 nov 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul William Henry Dixon come segretario in data 08 ago 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul William Henry Dixon come amministratore in data 08 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Paul William Henry Dixon come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Hubbard come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BAKER STREET GARAGE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIULLO, Salvatore | Amministratore | Oakwood Birhwood Dell BN4 6SY Doncaster South Yorkshire | England | British | 126363580001 | |||||
| DIXON, Simon Timothy | Amministratore | Main Street Hotham YO43 4UF York St Oswaleds House North Yorkshire | United Kingdom | British | 101291990002 | |||||
| DIXON, Paul William Henry | Segretario | The Square Anlaby House Estate Beverley Road, Anlaby HU10 7AY Hull 6 East Yorkshire United Kingdom | 163678240001 | |||||||
| DIXON, Paul William Henry | Segretario | Mill Estate Hotham YO43 4UG Hotham Yorkshire | British | 153357310001 | ||||||
| HUBBARD, Timothy James | Segretario | Sproatley Road HU2 8TT Preston 7 Hull | British | 128556090001 | ||||||
| NAYLOR, Peter Dennis | Segretario | 296 Beverley Road Anlaby HU10 7BG Hull North Humberside | British | 21736000001 | ||||||
| DERBYSHIRE, Sylvia | Amministratore | 275 Portobello Street HU9 5XX Hull North Humberside | British | 21736010001 | ||||||
| DIXON, Paul William Henry | Amministratore | Mill Estate Hotham YO43 4UG Hotham Yorkshire | United Kingdom | British | 153357310001 | |||||
| NAYLOR, Peter Dennis | Amministratore | 296 Beverley Road Anlaby HU10 7BG Hull North Humberside | British | 21736000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BAKER STREET GARAGE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marblechip Ltd | 06 apr 2016 | South Newbald Road North Newbald YO43 4RW York 1 Monkton Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BAKER STREET GARAGE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 12 mar 2009 Consegnato il 20 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 23 and 24 baker street hull land at reed street hull and land on the north side of baker street hull t/n's HS20278 KS191339 and HS277102, and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Corporate guarantee | Creato il 19 feb 2008 Consegnato il 26 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or marblechip limited to the bank of scotland PLC on any account whatsoever | |
Brevi particolari The company charges by way of a right of set-off all the companys present and future bank accounts cash at bank and credit balances and all rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 feb 2008 Consegnato il 05 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari T/No's HS191339 HS20278 and HS277102 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 18 lug 1977 Consegnato il 22 lug 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as no 23 & 24 baker street kingston-upon hall as comprised in a conveyance dated 3/6/77. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0