THAMES RICO LIMITED

THAMES RICO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHAMES RICO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01027878
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THAMES RICO LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova THAMES RICO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THAMES RICO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per THAMES RICO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU United Kingdom a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 10 lug 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Leopard Pel Limited come persona con controllo significativo il 02 lug 2018

    2 paginePSC05

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA

    legacy

    52 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 010278780007, creata il 19 giu 2017

    116 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 010278780006, creata il 22 dic 2016

    101 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 010278780005, creata il 07 nov 2016

    98 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Park Row Leeds LS1 5AB United Kingdom a Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU in data 01 lug 2016

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 1 Park Row Leeds LS1 5AB

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di THAMES RICO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    ALLAN, Timothy Edward Douglas
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    United KingdomBritish108784910001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54266450004
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    Hillfoot Road
    FK14 7PL By Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Hillfoot Road
    FK14 7PL By Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    ScotlandBritish82724480005
    FRENCH, David Michael
    Winfield The Warren
    East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Winfield The Warren
    East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    British54561370001
    HUNT, John Richard
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    Segretario
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    British51398860001
    JONES, Stephen John
    1 Larch Close
    Speen
    RG14 1UY Newbury
    Berkshire
    Segretario
    1 Larch Close
    Speen
    RG14 1UY Newbury
    Berkshire
    British73291560001
    MAGUIRE, John Michael
    3 Lincoln Court
    226 Willesden Lane
    NW2 5RG London
    Segretario
    3 Lincoln Court
    226 Willesden Lane
    NW2 5RG London
    British87426850001
    PAMELY, Philip
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    British36775580002
    SQUIRES, Michael John
    30 Melford Walk
    Nythe
    SN3 3RL Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    30 Melford Walk
    Nythe
    SN3 3RL Swindon
    Wiltshire
    British54681230001
    WRIGHT, Maureen Catherine
    36 Westfield Avenue
    WD2 4ED Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    36 Westfield Avenue
    WD2 4ED Watford
    Hertfordshire
    British3196840001
    BARNES, Robert Bruce
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    Amministratore
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    British38841560002
    DAWSON, Allan George
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    Amministratore
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    ScotlandBritish93178680001
    ESDALE, Gerald Paton Risett
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    Amministratore
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    British1938590001
    ESDALE, Patricia Joyce, Dr
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    Amministratore
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    EnglandBritish3684900001
    FALCONER, Ian
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    Amministratore
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    EnglandBritish49402550006
    FORSYTH, Angus Alpin
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    Amministratore
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish81456550001
    GARRY, Steven Bernard
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    United KingdomIrish132867110001
    HOOKHAM, Peter
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    Amministratore
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    UkBritish65880590006
    HUNT, John Richard
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    British51398860001
    LOWE, Peter John Harvey
    The Old Vicarage
    Church Lane Weston
    SG4 7DJ Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Church Lane Weston
    SG4 7DJ Hitchin
    Hertfordshire
    British32528670001
    SLADE, Dominic James Haviland
    13 Hasker Street
    SW3 2LE London
    Amministratore
    13 Hasker Street
    SW3 2LE London
    British111640410001
    STAGEN, Frank Peter
    14/20 Fifth Avenue
    Suite 2705
    FOREIGN Seattle
    Washington 98101
    Usa
    Amministratore
    14/20 Fifth Avenue
    Suite 2705
    FOREIGN Seattle
    Washington 98101
    Usa
    American24810900001
    WOODS, Dennis Laurence
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    EnglandEnglish19765000002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THAMES RICO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03391904
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THAMES RICO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2017
    Consegnato il 23 giu 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2016
    Consegnato il 16 nov 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 16 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 set 2015
    Consegnato il 04 set 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 04 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 23 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All the company’s estates or interests in any real property (as defined in the instrument. Evidencing the charge accompanying this form MR01) now or hereafter belonging to. It.. All the company’s rights under any agreement relating to the purchase of any. Freehold or leasehold property.. All the company's rights under any occupational lease, licence or other right of. Occupation.. All its right, title and interest in any intellectual property rights belonging to it or. (To the extent of its interest) in which it has an interest.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01)
    Transazioni
    • 23 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 ago 1997
    Consegnato il 09 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever including but not limited to the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery; the benefit of all licences; the goodwill and the uncalled capital; the book debts; the undertaking and all other property and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0