R. G. MANUFACTURING LIMITED

R. G. MANUFACTURING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR. G. MANUFACTURING LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01031681
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    • (2875) /
    • (3550) /

    Dove si trova R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kingswood House 71 The Avenue
    Cliftonville
    NN1 5BT Northampton
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHARD GRANT LIMITED26 giu 198926 giu 1989
    RICHARD GRANT MOTOR ACCESSORIES LIMITED18 nov 197118 nov 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2001
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 lug 2002
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2000

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al22 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    8 pagine1.4

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Varie

    O/C 20/06/02 rem/appts admins
    10 pagineMISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 06 mag 2002

    8 pagine1.3

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    6 pagine363s

    Varie

    O/C 23/12/99 rem/appt superv.
    9 pagineMISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 06 mag 2001

    11 pagine1.3

    Bilancio redatto al 30 set 2000

    11 pagineAA

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 06 mag 2000

    4 pagine1.3

    legacy

    6 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 1999

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagine395

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    6 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    legacy

    7 pagine395

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    legacy

    4 pagine395

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 1998

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 1997

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di R. G. MANUFACTURING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THORNTON, Rosemary Susan
    43 Barn Owl Close
    East Hunsbury
    NN4 0UA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    43 Barn Owl Close
    East Hunsbury
    NN4 0UA Northampton
    Northamptonshire
    BritishClerk122796940001
    THORNTON, Martin William
    43 Barn Owl Close
    NN4 0UA Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    43 Barn Owl Close
    NN4 0UA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishAc34336020002
    AYRTON, Christopher John
    Court House High Street
    Kimbolton
    PE18 0HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    Court House High Street
    Kimbolton
    PE18 0HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    British54296840001
    THORNTON, Martin William
    36 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    36 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    Northamptonshire
    EnglishAccountant34336020001
    AYRTON, Christopher John
    Court House High Street
    Kimbolton
    PE18 0HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Court House High Street
    Kimbolton
    PE18 0HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director54296840001
    BENTLEY, David William
    7 Bradgate Road
    MK40 3DE Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    7 Bradgate Road
    MK40 3DE Bedford
    Bedfordshire
    BritishOperations Director34336010001
    CLARK, Eric Raymond
    42 Vandyke Close
    Woburn Sands
    MK17 8UX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    42 Vandyke Close
    Woburn Sands
    MK17 8UX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director13548060001
    GRANT, Richard Dalton
    Edlesborough Mill
    Edlesborough
    LU6 1RU Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    Edlesborough Mill
    Edlesborough
    LU6 1RU Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director13548050001
    HART, Timothy Guy Collins
    Kingswood House
    The Lee
    HP16 9NU Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kingswood House
    The Lee
    HP16 9NU Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishInvestment Manager36699430002

    R. G. MANUFACTURING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge (supplemental to a debenture dated 13 february 1997)
    Creato il 01 nov 1999
    Consegnato il 11 nov 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    All right title and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 14 may 1999 between the company and close invoice finance limited and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 03 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A).fixed charge all book debts and other debts of the company both present and future including things in action which may give rise to such book debts and other debts sold by the company and purchased by the factor in accordance with the factoring agreement and not repurchased by the company pursuant to the provisions thereof b). Floating charge all book debts and other debts charged by way of fixed charge to the extent that such charge shall fail as fixed charges but without prejudice to any such fixed chartges as shall continue to be effective. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 03 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 05 mag 1999
    Consegnato il 12 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Itp victor, 3 axis co-ordinate measuring machine, manual traverse with 10 foot by 4 foot cast iron table and pc system serial number 1704, for details of further chattels please refer to form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 13TH february 1997 issued by the company
    Creato il 14 ott 1997
    Consegnato il 23 ott 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring, invoice discounting, or sales ledger financing agreement dated 26TH june 1997 and all book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 08 set 1997
    Consegnato il 15 set 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Addison DB89 cnc tube bending machine and all moneys received on any insurance whatsoever in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 13/2/97 issued by the company
    Creato il 13 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge over all rights title and interest in or arising out of a factoring,invoice discounting,or sales ledger financing agreement dated 17/10/96 between nmb-heller limited and the company and all book/other debts thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 13 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Nylon coating plant,ser/no 89/4214; addison DB632 bender,ser/no 8085-041; esab robotic welder,ser/no 004-70090-024.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 nov 1996
    Consegnato il 16 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under any factoring or invoice discounting agreement or arrangement or any loan or leasing agreement or arrangement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 lug 1993
    Consegnato il 16 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 23 ott 1992
    Consegnato il 28 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £23,682.84 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brevi particolari
    All its right,title and interest in and to all sums payable under the insurance for full details please see doc M216C.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 01 ott 1992
    Consegnato il 02 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof. Please see doc M52C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 02 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 15 feb 1991
    Consegnato il 20 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing payment of the rental and other monies due from the company to lloyds bank PLC (as trustee for the schroder exempt property unit trust) under the terms of a lease dated 31.8.90
    Brevi particolari
    The sum of sterling pounds 6,875 placed on deposit in an interest earning account in the name of the landlord with the bank or any balance thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank (As Trustee for the Schroder Exempt Property Unit Trust)
    Transazioni
    • 20 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 03 gen 1991
    Consegnato il 09 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 68371-95 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All its, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance, as from time to time varied or extended and the benefit of all powers and remedies for cancelling and/or enforcing the same.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 09 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1989
    Consegnato il 21 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heather works moor end eaton bray near dunstable bedfordshire. Title no. Bd 12570.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 04 nov 1988
    Consegnato il 10 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels, plant, machinery one new triblast rotary hook blast cleaning machine ser no. 2088/A460/9/3RH/1088 (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1987
    Consegnato il 16 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit K6 marley trading estate cherrycourt way stanbridge eggington bedfordshire t/n bd 84588.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1987
    Consegnato il 16 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a units K4 and K5 marley trading estate cherrycourt way stanbridge eggington bedfordshire t/n bd 78907.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises situate at the camp, eaton bray, nr dunstable, bedfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate at heather works, moor end, eaton bray, nr dunstable bedfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital & book debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 27 gen 1984
    Consegnato il 17 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1982
    Consegnato il 09 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a eaton bray site, bedfordshire T. no. Bd 12570.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1980
    Consegnato il 12 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H "the camp" eaton bray, nr dunstable bedfordshire bd 51127.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 12 ago 1980Registrazione di un'ipoteca

    R. G. MANUFACTURING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 mag 1999Data della riunione per approvare il CVA
    02 lug 2003Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robin Addy
    Oriel House
    55 Sheep St
    NN1 2NF Northampton
    Praticante
    Oriel House
    55 Sheep St
    NN1 2NF Northampton
    Paul Finnity
    Pricewaterhousecoopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    James Patrick Nicholas Martin
    Pricewaterhouse Coopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhouse Coopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    David R Wilton
    Pricewaterhousecoopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DataTipo
    26 ago 2003Conclusione della liquidazione
    18 lug 2002Data della petizione
    18 set 2002Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Northampton
    Scottish Life House
    29 St Katherines Street
    NN1 5GA Northampton
    Praticante
    Scottish Life House
    29 St Katherines Street
    NN1 5GA Northampton

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0