NATUREX LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NATUREX LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01032432 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NATUREX LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova NATUREX LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Givaudan Uk Limited Kennington Road Willesborough TN24 0LT Ashford Kent England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NATUREX LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OVERSEAL NATURAL INGREDIENTS LIMITED | 31 gen 2005 | 31 gen 2005 |
| OVERSEAL FOODS LIMITED | 24 nov 1971 | 24 nov 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NATUREX LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per NATUREX LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 01 giu 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 24 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Naturex, Societe Anonyme come persona con controllo significativo il 29 mag 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Park Road Overseal Swadlincote DE12 6JX United Kingdom a Givaudan Uk Limited Kennington Road Willesborough Ashford Kent TN24 0LT in data 21 gen 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Sean Cumiskey come amministratore in data 16 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Oreste Cesco Fieschi come amministratore in data 16 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alexis Laurent Mayer come amministratore in data 16 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Pradeep Parmar come amministratore in data 16 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony George Hunter come segretario in data 30 apr 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di NATUREX LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMISKEY, Sean | Amministratore | Kennington Road Willesborough TN24 0LT Ashford Givaudan Uk Limited Kent England | England | British | 252892670001 | |||||
| PARMAR, Pradeep | Amministratore | Kennington Road Willesborough TN24 0LT Ashford Givaudan Uk Limited Kent England | United Kingdom | British | 207660210001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Segretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HUNTER, Anthony George | Segretario | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | British | 66859190003 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Segretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Segretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| BARROCHE, Loic Joel | Amministratore | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | France | French | 217130900001 | |||||
| BOYD, Colin George | Amministratore | 14 Greville Drive Edgbaston B15 2UU Birmingham West Midlands | British | 807700001 | ||||||
| COLLINS, Paul | Amministratore | 268 Burton Road Midway Swadlincote DE23 6AA Derby Derbyshire | British | 81108830001 | ||||||
| DIKANSKY, Jacques Roger Maurice | Amministratore | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | France | French | 148095800001 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Amministratore | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FIESCHI, Oreste Cesco | Amministratore | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | France | Brazilian | 239369550001 | |||||
| FLEMING, Christine Jane | Amministratore | 7 St Peters Close Speen HP27 0SS Princes Risborough Buckinghamshire | British | 60958020002 | ||||||
| GAYDIER, Francois Marie | Amministratore | 28 Piso 3 08950 Esplugues De Llobregat Barcelona Carrer Juli Culebras I Barba Spain | French | 132793900002 | ||||||
| GREGORI BOHIGUES, Federico | Amministratore | C/San Vicente, No 95-6-6 FOREIGN Valencia Spain | Spanish | 109010600001 | ||||||
| HANDLEY, John Roland | Amministratore | The Old Vicarage Askham Bryan YO2 3QU York | British | 4407090001 | ||||||
| LAMBERT, Thierry Patrick | Amministratore | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | France | French | 148095790001 | |||||
| LEWIS, David | Amministratore | Pennyfield 9 Pitch Pond Close Knotty Green HP9 1XY Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69920630001 | |||||
| LOZANO-LOZANO, Daniel | Amministratore | 18--1-6b Madrid La Maso Street Spain | Spanish | 140001110001 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MAYER, Alexis Laurent | Amministratore | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | France | French | 239369050001 | |||||
| MCBRIDE, William Struan | Amministratore | 18 Coldharbour Lane Hildenborough TN11 9JT Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 49516770002 | |||||
| MONZO OLTRA, Honorato | Amministratore | Calle 221 No 63, 46182 La Canyada (Paterna) FOREIGN Valencia Spain | Spanish | 109010520001 | ||||||
| MORENO TARAZONA, Manuel | Amministratore | C/Alvaro De Bazan 12, 46010 FOREIGN Valencia Spain | Spanish | 107785860001 | ||||||
| PONS ANDREU, Jose Vicente | Amministratore | C/Denia, 58, Pl.2,, Pta 4, FOREIGN Valencia Spain | Spanish | 107650090001 | ||||||
| POPE, Sarah Joanne | Amministratore | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | England | English | 132792560001 | |||||
| RAFFY, Sylvain Patrice | Amministratore | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | France | French | 196937340001 | |||||
| RIGAUD, Ollivier Yvan Antoine Raphael | Amministratore | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | France | French | 196937350001 | |||||
| RUDDICK, Ian William | Amministratore | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Amministratore | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | United Kingdom | British | 42065200002 | |||||
| WAINWRIGHT, Andrew Mark | Amministratore | 8 Ambleside Gamston NG2 6NA Nottingham | England | British | 45418860003 | |||||
| WAINWRIGHT, Andrew Mark | Amministratore | 137 Blake Road West Bridgford NG2 5LA Nottingham | British | 45418860002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Amministratore | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | England | British | 37177620001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NATUREX LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givaudan Sa | 06 apr 2016 | 1214 Vernier Vernier 5 Chemin De La Parfumerie Switzerland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NATUREX LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creato il 29 gen 2009 Consegnato il 31 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 mag 2008 Consegnato il 02 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 03 nov 2001 Consegnato il 12 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known at park road, swains park estate, overseal t/no: LT327430. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 03 nov 2001 Consegnato il 07 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties (as defined) under the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creato il 11 set 2000 Consegnato il 23 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 13 apr 2000 Acquisito il 18 feb 2002 Consegnato il 22 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies owed by the seller to the secured parties | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 apr 1977 Consegnato il 27 apr 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & all buildings fixtures, fixed plant & machinery, fixed & floating charges. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0