BBI ENZYMES (UK) LIMITED

BBI ENZYMES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBBI ENZYMES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01034731
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. (20590) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BERRY SMITH LLP
    Haywood House Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIOZYME LABORATORIES LIMITED15 dic 197115 dic 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Edward Peterson come amministratore in data 06 ago 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Alexander Heinrich Werner Poempner come amministratore in data 27 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard George Armitt Couzens come amministratore in data 01 nov 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Alan Edward Peterson come amministratore in data 01 nov 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alexander Heinrich Werner Poempner il 01 feb 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mario Pietro Gualano il 01 feb 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Liam Mark Taylor come amministratore in data 16 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lyn Dafydd Rees come amministratore in data 16 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alexander Heinrich Werner Poempner come amministratore in data 16 gen 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mario Pietro Gualano come amministratore in data 16 gen 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Liam Mark Taylor il 02 lug 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Liam Taylor il 02 lug 2017

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUZENS, Richard George Armitt
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Amministratore
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    United KingdomBritish253439790001
    GUALANO, Mario Pietro
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Amministratore
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    EnglandBritish242829200001
    ANDERSON, Colin David
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    Segretario
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    United Kingdom44628230005
    JOHNSTON, Malcolm James
    107 Lavender Sweep
    Clapham
    SW11 1EA London
    Segretario
    107 Lavender Sweep
    Clapham
    SW11 1EA London
    British42155660001
    LLOYD SMITH, Lynda Joan
    Green Gables
    Gwmavon
    NP4 9LF Blaenavon
    Gwent
    Segretario
    Green Gables
    Gwmavon
    NP4 9LF Blaenavon
    Gwent
    British18589240001
    ROOKE, Joanne Bowden
    Rose Cottage
    36 Thistlecroft Road
    KT12 5QZ Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    Rose Cottage
    36 Thistlecroft Road
    KT12 5QZ Walton On Thames
    Surrey
    British51172180006
    ANDERSON, Colin David
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    Amministratore
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    United KingdomUnited Kingdom44628230005
    BARRY, Douglas John
    c/o Alere Inc
    Sawyer Road
    Suite 200
    02453 Waltham
    51
    Ma
    Usa
    Amministratore
    c/o Alere Inc
    Sawyer Road
    Suite 200
    02453 Waltham
    51
    Ma
    Usa
    UsaAmerican199784920001
    CHESHAM, John, Doctor
    3 Southwell Close
    Broad Oak
    HR2 8DZ Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    3 Southwell Close
    Broad Oak
    HR2 8DZ Hereford
    Herefordshire
    British58105320002
    COYNE, Raymond
    3 Bayfield Avenue
    Frimley
    GU16 5TT Camberley
    Surrey
    Amministratore
    3 Bayfield Avenue
    Frimley
    GU16 5TT Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish9354490001
    DOMINGO, Moreeda
    The Beeches
    54 Pen-Y-Pound
    NP7 7RW Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    The Beeches
    54 Pen-Y-Pound
    NP7 7RW Abergavenny
    Gwent
    British7705640001
    DOMINGO, Rashid
    43 Plas Derwen View
    NP7 9SX Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    43 Plas Derwen View
    NP7 9SX Abergavenny
    Gwent
    British7705630002
    HIGGINS, Irving John
    Cotswold Graze Hill
    Ravensden
    MK44 2TF Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Cotswold Graze Hill
    Ravensden
    MK44 2TF Bedford
    Bedfordshire
    British46344530001
    JONES, Graham Spencer
    5 Basildene Close
    Gilwern
    NP7 0AW Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    5 Basildene Close
    Gilwern
    NP7 0AW Abergavenny
    Gwent
    British26990860001
    MCNAMARA, Jay
    51 Sawyer Road
    Suite 200
    Waltham
    C/O Alere Inc
    Ma 02453
    Usa
    Amministratore
    51 Sawyer Road
    Suite 200
    Waltham
    C/O Alere Inc
    Ma 02453
    Usa
    UsaAmerican174859180001
    PETERSON, Alan Edward
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Amministratore
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    United KingdomBritish28231980004
    POEMPNER, Alexander Heinrich Werner
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Amministratore
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    GermanyGerman209810980001
    REES, Lyn Dafydd
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Amministratore
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    WalesBritish108878140002
    TAYLOR, Liam Mark
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Amministratore
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    WalesAustralian152099150002
    ADAM BIOTECHNOLOGY LIMITED
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Amministratore
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1912259
    124189850002
    BBI ENZYMES LIMITED
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Amministratore
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2815159
    45563930008
    CRANFIELD BIOTECHNOLOGY LIMITED
    C/O Theratase Ltd
    Golden Gate Tyglas Avenue
    CF14 5DX Cardiff
    Amministratore
    C/O Theratase Ltd
    Golden Gate Tyglas Avenue
    CF14 5DX Cardiff
    45920430005

    Chi sono le persone con controllo significativo di BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bbi Solutions Oem Limited
    Haywood House
    Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    C/O Berry Smith Llp
    Wales
    06 apr 2016
    Haywood House
    Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    C/O Berry Smith Llp
    Wales
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House, Uk
    Numero di registrazione08368483
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BBI ENZYMES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 14 set 2011
    Consegnato il 17 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/nos. CYM177636 and WA324229 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 06 lug 2011
    Consegnato il 19 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H broadoak enterprise village broadoak road sittingbourne t/nos K756811 K759614 K759616 and K180636 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 06 lug 2011
    Consegnato il 19 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/no WA333047 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2011
    Consegnato il 19 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 19 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 19 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 19 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings unit 15 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 07 ott 2008
    Consegnato il 28 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 28 apr 2004
    Consegnato il 05 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £40,000 credited to account designation 36046175 witht he bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 apr 2004
    Consegnato il 13 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and theratase PLC (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V., London Branch
    Transazioni
    • 13 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon gwent title number WA333047 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas estate blaenavon gwent title number WA324229 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 6 gilchrist-thomas estate blaenavon gwent south wales and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 ott 1987
    Consegnato il 02 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or biozyme laboratories international limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £65,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of land situate at gilchrist thomas industrial estate, blaenavon, in the county of gwent. Together with the factory erected thereon k/a:- unit 15 gilchrist thomas industrial estate.
    Persone aventi diritto
    • Torfaen Borough Council.
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 29 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 15 gilchrist thomas estate blaenavon, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1985
    Consegnato il 24 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 6, gilchrist thomas estate, blaenavon, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 gen 1972
    Consegnato il 14 gen 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and goodwill assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charge (see doc 7 for details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0