NOBBS & JONES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NOBBS & JONES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01035616 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NOBBS & JONES LIMITED?
- Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
Dove si trova NOBBS & JONES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NOBBS & JONES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per NOBBS & JONES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Archie Stuart Waddell come segretario in data 18 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Brian Dominic Sharma come segretario in data 18 set 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Aled Robert Humphreys come amministratore in data 18 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Archie Stuart Waddell come segretario in data 05 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come segretario in data 05 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di James Mcphillimy come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Brian Dominic Sharma come segretario in data 11 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Veronica Mary Niven come segretario in data 11 mag 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Brinsley Sheridan come amministratore in data 15 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Aled Robert Humphreys come amministratore in data 12 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2015 al 31 mar 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Richard Brinsley Sheridan come amministratore in data 21 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Michael Hillman come amministratore in data 21 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NOBBS & JONES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARMA, Brian Dominic | Segretario | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250774030001 | |||||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| BUDD, Gerald Lance | Segretario | Manston Road GU4 7YE Guildford 4 Surrey | British | 20717760001 | ||||||
| JONES, Christine | Segretario | Greenlands 64 Lightfoot Lane Fulwood PR2 3LT Preston Lancashire | British | 11422570001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Segretario | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 170751980001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Segretario | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190141580001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Segretario | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 173743100001 | |||||||
| PARKE, Gary | Segretario | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Segretario | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208039240001 | |||||||
| TOPP, Janice Susan | Segretario | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | Other | 139112080001 | ||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Segretario | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996560001 | |||||||
| BAETZ, Michael | Amministratore | 161 Bay Street, Suite 4540 PO BOX 709 M5J2S1 Toronto Canada Trust Tower Ontario Canada | Canada | Canadian | 166562600001 | |||||
| FRIGHT, Neil Grant | Amministratore | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 165864840002 | |||||
| GRIFFITHS, Derek John | Amministratore | 15 Crofters Green Euxton PR7 6LQ Chorley Lancashire | British | 67897220002 | ||||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Amministratore | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Amministratore | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||
| JONES, Christine | Amministratore | Greenlands 64 Lightfoot Lane Fulwood PR2 3LT Preston Lancashire | British | 11422570001 | ||||||
| JONES, Richard William | Amministratore | Greenlands 64 Lightfoot Lane Fulwood PR2 3LT Preston Lancashire | British | 11422580001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Amministratore | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670003 | |||||
| MCPHILLIMY, James | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||
| NIVEN, Veronica Mary | Amministratore | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 53122860001 | |||||
| PARKE, Gary | Amministratore | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| ROTHERAM, David Scott | Amministratore | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 67897320001 | |||||
| SCHNEIDER, Timothy John | Amministratore | Wyatt Close Wargrave RG10 8EB Reading 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150003200001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Amministratore | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Amministratore | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHLESINGER, Joseph Charles | Amministratore | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | Canada | Canadian | 139607450001 | |||||
| STEVENSON, Lawrence Napier | Amministratore | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | Canada | Canadian | 131305220002 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Amministratore | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 23661940005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NOBBS & JONES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve Energy Limited | 06 apr 2016 | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NOBBS & JONES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 02 nov 2012 Consegnato il 10 nov 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 lug 2012 Consegnato il 15 ago 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 21 lug 2011 Consegnato il 29 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 giu 2008 Consegnato il 24 giu 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 feb 1981 Consegnato il 24 feb 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 55A trafford street, preston, lancashire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 set 1975 Consegnato il 29 set 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All buildings fixtures, fixed because machinery by wayof fixed & floating charge (see doc M10 for more details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0