NOBBS & JONES LIMITED

NOBBS & JONES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNOBBS & JONES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01035616
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NOBBS & JONES LIMITED?

    • Installazione elettrica (43210) / Costruzioni

    Dove si trova NOBBS & JONES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NOBBS & JONES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per NOBBS & JONES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Archie Stuart Waddell come segretario in data 18 set 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Brian Dominic Sharma come segretario in data 18 set 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Aled Robert Humphreys come amministratore in data 18 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    8 pagineAA

    Nomina di Archie Stuart Waddell come segretario in data 05 lug 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come segretario in data 05 lug 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di James Mcphillimy come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Brian Dominic Sharma come segretario in data 11 mag 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Veronica Mary Niven come segretario in data 11 mag 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2016

    Stato del capitale al 03 mar 2016

    • Capitale: GBP 4,500
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Brinsley Sheridan come amministratore in data 15 ott 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Aled Robert Humphreys come amministratore in data 12 ago 2015

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2015 al 31 mar 2015

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2014

    7 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2015

    Stato del capitale al 03 mar 2015

    • Capitale: GBP 4,500
    SH01

    Nomina di Richard Brinsley Sheridan come amministratore in data 21 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Michael Hillman come amministratore in data 21 nov 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di NOBBS & JONES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARMA, Brian Dominic
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Segretario
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    250774030001
    GREENHORN, Kevin David Andrew
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Amministratore
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    ScotlandBritish145709970001
    BUDD, Gerald Lance
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    Segretario
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    British20717760001
    JONES, Christine
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    Segretario
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    British11422570001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    170751980001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Segretario
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    190141580001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    173743100001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    SHARMA, Brian Dominic
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    208039240001
    TOPP, Janice Susan
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Other139112080001
    WADDELL, Archie Stuart
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Segretario
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    234996560001
    BAETZ, Michael
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian166562600001
    FRIGHT, Neil Grant
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish165864840002
    GRIFFITHS, Derek John
    15 Crofters Green
    Euxton
    PR7 6LQ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    15 Crofters Green
    Euxton
    PR7 6LQ Chorley
    Lancashire
    British67897220002
    HILLMAN, Christopher Michael
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish17572470002
    HUMPHREYS, Aled Robert
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Amministratore
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish200150330001
    JONES, Christine
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    British11422570001
    JONES, Richard William
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Greenlands 64 Lightfoot Lane
    Fulwood
    PR2 3LT Preston
    Lancashire
    British11422580001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish18996670003
    MCPHILLIMY, James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Amministratore
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish94397700001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish53122860001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    ROTHERAM, David Scott
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish67897320001
    SCHNEIDER, Timothy John
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian150003200001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Amministratore
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHLESINGER, Joseph Charles
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    CanadaCanadian139607450001
    STEVENSON, Lawrence Napier
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    CanadaCanadian131305220002
    TENNENT, Colin Robert
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish23661940005

    Chi sono le persone con controllo significativo di NOBBS & JONES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05831752
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NOBBS & JONES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 nov 2012
    Consegnato il 10 nov 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (T/a Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 10 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2012
    Consegnato il 15 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bbtps L.P
    Transazioni
    • 15 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 lug 2011
    Consegnato il 29 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 29 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2008
    Consegnato il 24 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 1981
    Consegnato il 24 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 55A trafford street, preston, lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 24 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 set 1975
    Consegnato il 29 set 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All buildings fixtures, fixed because machinery by wayof fixed & floating charge (see doc M10 for more details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 29 set 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0