OIL & GAS PROJECTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | OIL & GAS PROJECTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01036047 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | ELWELL WATCHORN & SAXTON LLP 8 Warren Park Way Enderby LE19 4SA Leicester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ACCURA TRADING LIMITED | 03 apr 2017 | 03 apr 2017 |
LINVIC ENGINEERING LIMITED | 23 dic 1971 | 23 dic 1971 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 13 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2021 | 13 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael William Richards come amministratore in data 11 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 109 Swan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN a 8 Warren Park Way Enderby Leicester LE19 4SA in data 18 dic 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2020 | 16 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2019 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 109 Pswan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN a 109 Swan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN in data 01 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Close Willenhall WV13 1NS England a 109 Pswan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN in data 18 set 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 8 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Williams come amministratore in data 08 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stuart David Maddison come amministratore in data 05 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael William Richards come amministratore in data 11 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Heath Lee Walker come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS England a 1 Stringes Close Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS England a 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hickman Avenue Wolverhampton West Midlands WV1 2EN a 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Heath Lee Walker come amministratore in data 30 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Alexander Joss come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Alexander Barr come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADDISON, Stuart David | Amministratore | Warren Park Way Enderby LE19 4SA Leicester 8 | England | British | Director | 242898400001 | ||||
HAGUE, Sheila | Segretario | Noverton Nurton Hill Road Pattingham WV6 7HQ Wolverhampton West Midlands | English | 16672500001 | ||||||
URQUHART, Graham Kenneth | Segretario | Woodside Road KT3 3AW New Malden 61 Surrey | British | 6005660002 | ||||||
SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 500-600 Witan Gate West MK9 1SH Milton Keynes Witan Gate House | 76282680012 | |||||||
ANDREWS, Peter Joseph | Amministratore | Broad Oak HR2 8QX Hereford Lower Whitelands Farm Herefordshire | United Kingdom | British | Director | 129541860001 | ||||
ARMSTRONG, Simon John | Amministratore | Orchard House Heatherwold, Newtown RG20 9BG Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 36395020005 | ||||
BARR, Francis Alexander | Amministratore | WV1 2EN Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands | England | British | Company Director | 93782330002 | ||||
FLETCHER, John Mcmillian | Amministratore | Bayswater Road Lower Gornal DY3 2QS Dudley 21 West Midlands | United Kingdom | British | Warehousing Director | 65246930002 | ||||
GOULDINGAY, David Charles | Amministratore | 430 Quinton Road West Quinton B32 1QG Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 61316450001 | ||||
HAGUE, John Stuart | Amministratore | Noverton Nurton Hill Road Pattingham WV6 7HQ Wolverhampton West Midlands | English | Managing Director | 37194900001 | |||||
HAGUE, Sheila | Amministratore | Noverton Nurton Hill Road Pattingham WV6 7HQ Wolverhampton West Midlands | English | Secretary | 16672500001 | |||||
HILL, Stephen Richard | Amministratore | Chute Collis Upper Chute SP11 9EF Andover Hampshire | United Kingdom | British | Investment Banker | 35528310003 | ||||
JOSS, William Alexander | Amministratore | WV1 2EN Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands | England | British | Company Director | 72152610003 | ||||
LELLOW, Simon | Amministratore | Avondale Newport TF10 7LP Telford 15 Shropshire | United Kingdom | British | Production Director | 57018140003 | ||||
LUCKETT, Nigel Frederick | Amministratore | 108 White Hill Kinver DY7 6AU Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 31248240001 | ||||
NORRIS, Michael John | Amministratore | 5 Fitzwilliam Avenue TW9 2DQ Richmond Surrey | England | British | Chartered Accountant | 78716940001 | ||||
RALPH, Daniel Oliver | Amministratore | WV1 2EN Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136410060001 | ||||
RICHARDS, Michael William | Amministratore | Warren Park Way Enderby LE19 4SA Leicester 8 | United Kingdom | British | Company Director | 11360230003 | ||||
RUGEN, Robert John | Amministratore | Parkside Industrial Estate Hickman Avenue WV1 2EN Wolverhampton Unit 7 England | United Kingdom | British | Technical Director | 182679870002 | ||||
SCOTT, Colin | Amministratore | 19 Heyville Croft CV8 2SR Kenilworth Warwickshire | England | British | Consultant | 15620630002 | ||||
SMITH, Alan | Amministratore | WV1 2DW Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands | British | Managing Director | 56591610005 | |||||
WALKER, Heath Lee | Amministratore | Stringes Close WV13 1NS Willenhall 1 England | England | British | Company Director | 174700320001 | ||||
WESTWOOD, Peter | Amministratore | WV1 2EN Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands United Kingdom | Uk | British | Director | 90550270002 | ||||
WILCOX, Ann Georgina | Amministratore | WV1 2EN Wolverhampton Hickman Avenue West Midlands | England | British | Commercial Director | 57018270003 | ||||
WILLIAMS, David John | Amministratore | Stringes Close WV13 1NS Willenhall 1 England | United Kingdom | British | Company Director | 190174540001 | ||||
WILSON, Kevin | Amministratore | Poolhead Lane Tanworth-In-Arden B94 5ED Solihull Highland West Midlands | England | British | Engineer | 134562630001 | ||||
WRIGHT, Craig Richard | Amministratore | Charlecote House Weaverlake Drive DE13 8AD Yoxall Staffordshire | England | British | Chartered Accountant | 58301380002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accura Finance Ltd | 18 ott 2016 | Hickman Avenue WV1 2DW Wolverhampton Hickman Avenue England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OIL & GAS PROJECTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 23 gen 2014 Consegnato il 11 feb 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 ago 2008 Consegnato il 21 ago 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge containing fixed and floating charges | Creato il 24 apr 1997 Consegnato il 02 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H-unit 3B parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton legal mortgage over all the property as described above; by way of fixed charge all buildings, goodwill, plant & machinery; by way of floating charge all unattached plant & machinery; by way of assignment the rental sums; by way of fixed charge the proceeds of any claim.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge containing fixed and floating charges | Creato il 24 apr 1997 Consegnato il 02 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H unit 3A parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton t/n-WM133059 legal mortgage over all the property as described above; by way of fixed charge all buildings, goodwill, plant & machinery; by way of floating charge all unattached plant & machinery; by way of assignment the rental sums; by way of fixed charge the proceeds of any claim.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 06 mar 1997 Consegnato il 14 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a units 1 and 2 parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton west midlands t/no: WM46788; fixed and floating charge over plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 mar 1997 Consegnato il 14 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 apr 1984 Consegnato il 04 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £178,000 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery including all other property & assets in scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over contract | Creato il 07 gen 1982 Consegnato il 15 gen 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the benefit of an agreement dated 14THE dec. 1981 in respect of computer equipment leased to premier computers (leasing) limited and sub-leased to 3M united kingdom limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 25 nov 1981 Consegnato il 01 dic 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 18.11.81. | |
Brevi particolari All the company's interest in an agreement dated 26.11.81, the equipment therein moneys payable and benefit of guaranteees etc. (see doc M24). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 30 ott 1981 Consegnato il 16 nov 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All rights, title and benefit of the mortgages in and to an equipment lease agreement dated 30TH oct. 1981. together with the benefit of all guarantees issued in favour of the mortgages in connection with the equipment lease agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 30 ott 1981 Consegnato il 16 nov 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All rights, title and benefit of the mortgages in and to an equipment lease agreement dated 30TH oct. 1981. together with the benefit of all guarantees issued in favour of the mortgages in connection with the equipment lease agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 1981 Consegnato il 15 mag 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The benefit of an agreement dated 19.12.1980 in respect of certain computer equipment leased to premier computers (leasing) LTD and sub-leased to 3M united kingdom LTD and the benefit of a guarantee dated 20.1.81 given by security pacific corporation to linvic in respect of above agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 1981 Consegnato il 15 mag 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The benefit of an agreement dated 10.12.1980 in respect of certain computer equipment leased to premier computers (leasing) LTD & subleased to a goldberg and sons LTD & the benefit of a guarantee dated 12.12.80 given by security pacific corporation. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 29 dic 1980 Consegnato il 31 dic 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29TH dec. 1980. | |
Brevi particolari All rights,title and benefit of the mortgagor in and to an equipment lease agreement dated 29.12.80. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 21 dic 1977 Consegnato il 10 gen 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase agreement dated 21/12/77. | |
Brevi particolari All payments or sums of money payable under an equipment use agreement dated 21.12.77 with daf trucks finance (UK) LTD. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 21 dic 1977 Consegnato il 10 gen 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase agreement dated 21/12/77 | |
Brevi particolari All payments or sums of money payable under an equipment use agreement dated 21/12/77 with crane fruehauf finance LTD. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
OIL & GAS PROJECTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0