OIL & GAS PROJECTS LIMITED

OIL & GAS PROJECTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOIL & GAS PROJECTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01036047
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    ELWELL WATCHORN & SAXTON LLP
    8 Warren Park Way Enderby
    LE19 4SA Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACCURA TRADING LIMITED03 apr 201703 apr 2017
    LINVIC ENGINEERING LIMITED23 dic 197123 dic 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2021

    13 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Michael William Richards come amministratore in data 11 giu 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 109 Swan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN a 8 Warren Park Way Enderby Leicester LE19 4SA in data 18 dic 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2020

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ago 2019

    12 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 109 Pswan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN a 109 Swan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN in data 01 ott 2018

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Close Willenhall WV13 1NS England a 109 Pswan Street Sileby Leicestershire LE12 7NN in data 18 set 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 24 ago 2018

    LRESEX

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 lug 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 lug 2018

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di David John Williams come amministratore in data 08 feb 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stuart David Maddison come amministratore in data 05 feb 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael William Richards come amministratore in data 11 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Heath Lee Walker come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS England a 1 Stringes Close Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS England a 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Hickman Avenue Wolverhampton West Midlands WV1 2EN a 1 Stringes Lane Willenhall WV13 1NS in data 09 ott 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Heath Lee Walker come amministratore in data 30 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Alexander Joss come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Francis Alexander Barr come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MADDISON, Stuart David
    Warren Park Way
    Enderby
    LE19 4SA Leicester
    8
    Amministratore
    Warren Park Way
    Enderby
    LE19 4SA Leicester
    8
    EnglandBritishDirector242898400001
    HAGUE, Sheila
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    English16672500001
    URQUHART, Graham Kenneth
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    Segretario
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    British6005660002
    SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED
    500-600 Witan Gate West
    MK9 1SH Milton Keynes
    Witan Gate House
    Segretario
    500-600 Witan Gate West
    MK9 1SH Milton Keynes
    Witan Gate House
    76282680012
    ANDREWS, Peter Joseph
    Broad Oak
    HR2 8QX Hereford
    Lower Whitelands Farm
    Herefordshire
    Amministratore
    Broad Oak
    HR2 8QX Hereford
    Lower Whitelands Farm
    Herefordshire
    United KingdomBritishDirector129541860001
    ARMSTRONG, Simon John
    Orchard House
    Heatherwold, Newtown
    RG20 9BG Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Orchard House
    Heatherwold, Newtown
    RG20 9BG Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector36395020005
    BARR, Francis Alexander
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    Amministratore
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director93782330002
    FLETCHER, John Mcmillian
    Bayswater Road
    Lower Gornal
    DY3 2QS Dudley
    21
    West Midlands
    Amministratore
    Bayswater Road
    Lower Gornal
    DY3 2QS Dudley
    21
    West Midlands
    United KingdomBritishWarehousing Director65246930002
    GOULDINGAY, David Charles
    430 Quinton Road West
    Quinton
    B32 1QG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    430 Quinton Road West
    Quinton
    B32 1QG Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant61316450001
    HAGUE, John Stuart
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    EnglishManaging Director37194900001
    HAGUE, Sheila
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Noverton Nurton Hill Road
    Pattingham
    WV6 7HQ Wolverhampton
    West Midlands
    EnglishSecretary16672500001
    HILL, Stephen Richard
    Chute Collis
    Upper Chute
    SP11 9EF Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Chute Collis
    Upper Chute
    SP11 9EF Andover
    Hampshire
    United KingdomBritishInvestment Banker35528310003
    JOSS, William Alexander
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    Amministratore
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director72152610003
    LELLOW, Simon
    Avondale
    Newport
    TF10 7LP Telford
    15
    Shropshire
    Amministratore
    Avondale
    Newport
    TF10 7LP Telford
    15
    Shropshire
    United KingdomBritishProduction Director57018140003
    LUCKETT, Nigel Frederick
    108 White Hill
    Kinver
    DY7 6AU Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    108 White Hill
    Kinver
    DY7 6AU Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director31248240001
    NORRIS, Michael John
    5 Fitzwilliam Avenue
    TW9 2DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    5 Fitzwilliam Avenue
    TW9 2DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant78716940001
    RALPH, Daniel Oliver
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136410060001
    RICHARDS, Michael William
    Warren Park Way
    Enderby
    LE19 4SA Leicester
    8
    Amministratore
    Warren Park Way
    Enderby
    LE19 4SA Leicester
    8
    United KingdomBritishCompany Director11360230003
    RUGEN, Robert John
    Parkside Industrial Estate
    Hickman Avenue
    WV1 2EN Wolverhampton
    Unit 7
    England
    Amministratore
    Parkside Industrial Estate
    Hickman Avenue
    WV1 2EN Wolverhampton
    Unit 7
    England
    United KingdomBritishTechnical Director182679870002
    SCOTT, Colin
    19 Heyville Croft
    CV8 2SR Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    19 Heyville Croft
    CV8 2SR Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritishConsultant15620630002
    SMITH, Alan
    WV1 2DW Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    Amministratore
    WV1 2DW Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    BritishManaging Director56591610005
    WALKER, Heath Lee
    Stringes Close
    WV13 1NS Willenhall
    1
    England
    Amministratore
    Stringes Close
    WV13 1NS Willenhall
    1
    England
    EnglandBritishCompany Director174700320001
    WESTWOOD, Peter
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    United Kingdom
    UkBritishDirector90550270002
    WILCOX, Ann Georgina
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    Amministratore
    WV1 2EN Wolverhampton
    Hickman Avenue
    West Midlands
    EnglandBritishCommercial Director57018270003
    WILLIAMS, David John
    Stringes Close
    WV13 1NS Willenhall
    1
    England
    Amministratore
    Stringes Close
    WV13 1NS Willenhall
    1
    England
    United KingdomBritishCompany Director190174540001
    WILSON, Kevin
    Poolhead Lane
    Tanworth-In-Arden
    B94 5ED Solihull
    Highland
    West Midlands
    Amministratore
    Poolhead Lane
    Tanworth-In-Arden
    B94 5ED Solihull
    Highland
    West Midlands
    EnglandBritishEngineer134562630001
    WRIGHT, Craig Richard
    Charlecote House
    Weaverlake Drive
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Amministratore
    Charlecote House
    Weaverlake Drive
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant58301380002

    Chi sono le persone con controllo significativo di OIL & GAS PROJECTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Accura Finance Ltd
    Hickman Avenue
    WV1 2DW Wolverhampton
    Hickman Avenue
    England
    18 ott 2016
    Hickman Avenue
    WV1 2DW Wolverhampton
    Hickman Avenue
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione6613078
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    OIL & GAS PROJECTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 gen 2014
    Consegnato il 11 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 15 ago 2008
    Consegnato il 21 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 24 apr 1997
    Consegnato il 02 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-unit 3B parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton legal mortgage over all the property as described above; by way of fixed charge all buildings, goodwill, plant & machinery; by way of floating charge all unattached plant & machinery; by way of assignment the rental sums; by way of fixed charge the proceeds of any claim.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 24 apr 1997
    Consegnato il 02 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 3A parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton t/n-WM133059 legal mortgage over all the property as described above; by way of fixed charge all buildings, goodwill, plant & machinery; by way of floating charge all unattached plant & machinery; by way of assignment the rental sums; by way of fixed charge the proceeds of any claim.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 1 and 2 parkside industrial estate hickman avenue wolverhampton west midlands t/no: WM46788; fixed and floating charge over plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 1984
    Consegnato il 04 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £178,000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery including all other property & assets in scotland.
    Persone aventi diritto
    • Ralin Holdings PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over contract
    Creato il 07 gen 1982
    Consegnato il 15 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 14THE dec. 1981 in respect of computer equipment leased to premier computers (leasing) limited and sub-leased to 3M united kingdom limited.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 25 nov 1981
    Consegnato il 01 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 18.11.81.
    Brevi particolari
    All the company's interest in an agreement dated 26.11.81, the equipment therein moneys payable and benefit of guaranteees etc. (see doc M24).
    Persone aventi diritto
    • Algemene Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 01 dic 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 21 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 30 ott 1981
    Consegnato il 16 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All rights, title and benefit of the mortgages in and to an equipment lease agreement dated 30TH oct. 1981. together with the benefit of all guarantees issued in favour of the mortgages in connection with the equipment lease agreement.
    Persone aventi diritto
    • Chemico Equipment Finance Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 30 ott 1981
    Consegnato il 16 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All rights, title and benefit of the mortgages in and to an equipment lease agreement dated 30TH oct. 1981. together with the benefit of all guarantees issued in favour of the mortgages in connection with the equipment lease agreement.
    Persone aventi diritto
    • Chemico Equipment Finance Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1981
    Consegnato il 15 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of an agreement dated 19.12.1980 in respect of certain computer equipment leased to premier computers (leasing) LTD and sub-leased to 3M united kingdom LTD and the benefit of a guarantee dated 20.1.81 given by security pacific corporation to linvic in respect of above agreement.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1981
    Consegnato il 15 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of an agreement dated 10.12.1980 in respect of certain computer equipment leased to premier computers (leasing) LTD & subleased to a goldberg and sons LTD & the benefit of a guarantee dated 12.12.80 given by security pacific corporation.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 29 dic 1980
    Consegnato il 31 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29TH dec. 1980.
    Brevi particolari
    All rights,title and benefit of the mortgagor in and to an equipment lease agreement dated 29.12.80.
    Persone aventi diritto
    • Chemco Equipment Finance Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 21 dic 1977
    Consegnato il 10 gen 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase agreement dated 21/12/77.
    Brevi particolari
    All payments or sums of money payable under an equipment use agreement dated 21.12.77 with daf trucks finance (UK) LTD.
    Persone aventi diritto
    • Daf Trucks Finance UK Limited
    Transazioni
    • 10 gen 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 21 dic 1977
    Consegnato il 10 gen 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase agreement dated 21/12/77
    Brevi particolari
    All payments or sums of money payable under an equipment use agreement dated 21/12/77 with crane fruehauf finance LTD.
    Persone aventi diritto
    • Crane Fruehauf Finance (Leasing) Limited
    Transazioni
    • 10 gen 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OIL & GAS PROJECTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 ago 2018Inizio della liquidazione
    25 gen 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Graham Stuart Wolloff
    Elwell Watchorn & Saxton
    2 Axon
    PE2 6LR Commerce Road
    Lynchwood Peterborough
    Praticante
    Elwell Watchorn & Saxton
    2 Axon
    PE2 6LR Commerce Road
    Lynchwood Peterborough
    Mark Grahame Tailby
    109 Swan Street
    Sileby
    LE12 7NN Loughborough
    Leicestershire
    Praticante
    109 Swan Street
    Sileby
    LE12 7NN Loughborough
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0