VENTRON TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | VENTRON TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01036947 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 09 gen 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Euston Tower 286 Euston Road London NW1 3AT England a Epsom Gateway 2 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5AL | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Heath Stewart Drewett come amministratore in data 15 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2018 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Glenister Cole come amministratore in data 14 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Elliot Michael Nobelen come segretario in data 29 set 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashley Louise Gerrard come segretario in data 28 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Lindsay come segretario in data 28 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Louise Mary Mcallister come segretario in data 29 set 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Stephen Anderson come amministratore in data 01 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Webster come amministratore in data 31 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Webster il 09 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCALLISTER, Louise Mary | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238795870001 | |||||||
| NOBELEN, Elliot Michael | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238796430001 | |||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 122463830003 | |||||
| COLE, Simon Glenister | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 146000480001 | |||||
| CULLENS, Alan James | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 189297280001 | |||||
| BAKER, Helen Alice | Segretario | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 108742050002 | ||||||
| DAVID, Katie Charmian | Segretario | 31 Sandy Lane TN13 3TP Sevenoaks Kent | British | 73696680003 | ||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Segretario | Hartland Woodside Drive RG18 9QD Hermitage Berkshire | British | 71932630003 | ||||||
| GERRARD, Ashley Louise | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218094650001 | |||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Segretario | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| HOBSON, Muriel Elizabeth | Segretario | Talfourd Cumber Close SK9 6ED Wilmslow Cheshire | British | 13540910001 | ||||||
| LINDSAY, Catherine Elizabeth | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218252880001 | |||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Segretario | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| TOMALIN, Richard Howarth | Segretario | 22 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | British | 13199870002 | ||||||
| WEBSTER, Richard | Segretario | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 85595860003 | ||||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BRANDEIS, Anthony Michael | Amministratore | 468b Bury New Road Salford M7 4NU Greater Manchester Lancashire | England | British | 13568750001 | |||||
| COSGRIFF, Vincent John | Amministratore | 15 Cavendish Road M7 4WP Salford Lancashire | British | 20782080001 | ||||||
| CUTHBERT, Richard Harry | Amministratore | Saxons Meath Green Lane RH6 8JA Horley Surrey | United Kingdom | British | 43573230002 | |||||
| DREWETT, Heath Stewart | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 167727030003 | |||||
| GIBBONS, Michael Charles | Amministratore | 48 St Mary's Road M33 6SA Sale Cheshire | British | 48263260001 | ||||||
| GRANT, Martin Macdonald, Dr | Amministratore | Connel Ha Cothal Dyce AB21 0JN Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 66883910003 | |||||
| GRIFFITHS, Alun Hughes | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 47764900002 | |||||
| HOBSON, Rawnsley James, Dr | Amministratore | Talfourd Cumber Close SK9 6ED Wilmslow Cheshire | England | British | 13540920001 | |||||
| JOHNSON, Steven | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 161365240001 | |||||
| LONG, Richard Charles | Amministratore | 15 Downs Road KT18 5JF Epsom Surrey | Uk | British | 30556100002 | |||||
| MACLEOD, Robert James | Amministratore | Guildford Road GU6 8LT Cranleigh Norther Farm Surrey | United Kingdom | British | 90186680002 | |||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Amministratore | 4 Arden Court 20 Avenue Elmers KT6 4SE Surbiton Surrey | British | 36957420003 | ||||||
| MCCLEAN, James Constantine Stuart | Amministratore | Waterfield, Petworth Road Chiddingfold GU8 4UF Godalming Surrey | England | British | 121347960001 | |||||
| PIPER, Richard John | Amministratore | Merryfield St Georges Road BR1 2LD Bickley Kent | England | British | 36504290001 | |||||
| PURSER, Ian Robert | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 61343830005 | |||||
| WEBSTER, Richard | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 265907550001 | |||||
| YATES, James Alan | Amministratore | 19 Bean Leach Avenue SK2 5JA Stockport Cheshire | England | British | 100237070001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VENTRON TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkins Limited | 06 apr 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
VENTRON TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creato il 03 set 1999 Consegnato il 08 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re ventron technology limited and numbered 7057435 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 31 gen 1997 Consegnato il 17 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from synprotec limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 303 clayton lane manchester M11 4SX together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery goodwill and benefit of licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 31 gen 1997 Consegnato il 17 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from anthony michael brandeis, rawnsley james hobson and peter david nightingale to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 303 clayton lane manchester M11 4SX together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery goodwill and benefit of licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 14 lug 1994 Consegnato il 20 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Counter indemnity | Creato il 22 mar 1989 Consegnato il 12 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari £123815 standing in or to be credited to a designated account with lloyd bank PLC & all interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Counter indeminity & charge on deposit | Creato il 27 gen 1987 Consegnato il 02 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £70900 standing to a designated account with lloyds bank (fixed charge). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment & charges | Creato il 31 mag 1984 Consegnato il 21 giu 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a design & build contract dated 9.3.86 & the charge | |
Brevi particolari Assignment of all the right title & interest of the charges in the debt of £300,000 owed or to be owed to the chargor on account no 0334654 etc. first specific equitable charge the proceeds of the deposit debt & all other amounts which from time to time shall accrue & be payable in respect of the deposit debt (see doc M37). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0