EUROSTYLE FURNITURE LIMITED
Panoramica
Nome della società | EUROSTYLE FURNITURE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01037617 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Holmfield Industrial Estate Holmfield HX2 9TN Halifax West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GOWER INTERNATIONAL LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
LADYSHIP INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED | 10 gen 1972 | 10 gen 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 25 set 2018
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Nicola Jane Saul il 30 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Nicola Saul il 30 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Nicola Jane Saul il 17 ott 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDCASTLE, Nicola Jane | Segretario | Holmfield Industrial Estate Holmfield HX2 9TN Halifax West Yorkshire | 155712630002 | |||||||
HARDCASTLE, Nicola Jane | Amministratore | Holmfield Industrial Estate Holmfield HX2 9TN Halifax West Yorkshire | England | British | Accountant | 155589530003 | ||||
MORAN, Ruth | Segretario | 502 Broad Lane LS13 3HB Leeds West Yorkshire | British | 48139970001 | ||||||
OHLE, Kevin | Segretario | Rosegarth 44 Grove Road LS29 9QF Ilkley West Yorkshire | Irish | 2792680005 | ||||||
WORMWELL, Alan | Segretario | 10 The Spinney HD6 2JW Brighouse West Yorkshire | British | 21380090002 | ||||||
BULLIVANT, Paul Ernest | Amministratore | 9 Springfield Rise YO5 9SE Great Ouseburn York | British | Company Director | 42900770001 | |||||
BULLOCK, David Christopher | Amministratore | Hawthorne Cottage 239 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Staffordshire | British | Managing Director | 107514490001 | |||||
ELGOOD, Martin James | Amministratore | The Red House 32 Grove Road LS29 9QE Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 54744400003 | ||||
FRIEND, Nicholas Giovanni Lewis | Amministratore | Calver Mill Calver S32 3YU Hope Valley 21 Derbyshire United Kingdom | England | British | M D | 121305220002 | ||||
HARPER, Frank Russell | Amministratore | 2 Broadstairs Close Sutton HU8 9UR Hull North Humberside | British | Director | 36159960001 | |||||
MORAN, Ruth | Amministratore | 502 Broad Lane LS13 3HB Leeds West Yorkshire | England | British | Finance Director | 48139970001 | ||||
MORAN, Ruth | Amministratore | 502 Broad Lane LS13 3HB Leeds West Yorkshire | England | British | Accountant | 48139970001 | ||||
OHLE, Kevin | Amministratore | Rosegarth 44 Grove Road LS29 9QF Ilkley West Yorkshire | Irish | Director | 2792680005 | |||||
REYNOLDS, Richard Hugh | Amministratore | Brentwood Denton LS29 0HE Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 2059970002 | ||||
WORMWELL, Alan | Amministratore | 10 The Spinney HD6 2JW Brighouse West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 21380090002 | |||||
WRIGLEY, Peter Anthony | Amministratore | 24 Wyre Avenue Kirkham PR4 2YE Preston Lancashire | England | British | Sales Director | 2376880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EUROSTYLE FURNITURE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gower Furniture Limited | 06 apr 2016 | Holmfield Industrial Estate Holmfield HX2 9TN Halifax Gower Furniture Limited England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
EUROSTYLE FURNITURE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 20 set 1994 Consegnato il 03 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings lying to the west of topcliffe lane morley west yorkshire t/n wyk 320232. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 set 1994 Consegnato il 03 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the south side of glen road morley west yorkshire t/n wyk 251482. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 set 1994 Consegnato il 03 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings lying to the south east of glen road topcliffe lane morley west midlands t/n wyk 359807. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 set 1994 Consegnato il 03 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the west side of topcliffe lane morley west yorkshire t/n wyk 320231. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 dic 1991 Consegnato il 08 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from charco ninety nine limited to nat west investment bank limited as trustee for the noteholders (as defined) under the terms of a loan note instrument dated 24TH december 1991 | |
Brevi particolari (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 19 giu 1986 Consegnato il 04 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 01 ago 1980 Consegnato il 12 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0