MOORGATE INDUSTRIES LIMITED

MOORGATE INDUSTRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOORGATE INDUSTRIES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01038435
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEMCOR HOLDINGS LIMITED08 feb 198808 feb 1988
    STEMCOR LIMITED11 gen 198811 gen 1988
    STELCOR LIMITED04 gen 198804 gen 1988
    IRENE SECURITIES LIMITED14 gen 197214 gen 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    16 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    15 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    15 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    16 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    15 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    15 pagineWU07

    Soddisfazione dell'onere 010384350014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350020 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350022 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350021 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350023 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350027 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010384350025 in pieno

    4 pagineMR04

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    15 pagineWU07

    Prosecuzione del comitato dei creditori

    7 pagineCOM3

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    27 pagineAM25

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 More London Riverside London SE1 2RT a 25 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 22 ott 2018

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Dimissioni di un amministratore

    13 pagineAM15

    Chi sono gli amministratori di MOORGATE INDUSTRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SODEN, John Francis
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish68179870004
    CROSSIN, Nicholas Hugh
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    Segretario
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    British193585010001
    DONNELL, Graham
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    Segretario
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    184823140001
    GOLDSMITH, Andrew Stanley
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    England Uk
    Segretario
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    England Uk
    British73440100002
    KAIZER, Alan Derek
    61 Middleton Gardens
    Gants Hill
    IG2 6DX Ilford
    Essex
    Segretario
    61 Middleton Gardens
    Gants Hill
    IG2 6DX Ilford
    Essex
    British6034570001
    LEVINE, Brian Allen
    Villa Amaryllis
    403 Allee Du Redon
    Mouans Sartoux
    06370
    France
    Segretario
    Villa Amaryllis
    403 Allee Du Redon
    Mouans Sartoux
    06370
    France
    British125106270001
    PAUL, David John
    5 Aldermary Road
    BR1 3PH Bromley
    Kent
    Segretario
    5 Aldermary Road
    BR1 3PH Bromley
    Kent
    British15574420001
    BLOHM, Peter Hans
    387 Mill River Road Oyster Bay
    Ny 11771
    New York
    Usa
    Amministratore
    387 Mill River Road Oyster Bay
    Ny 11771
    New York
    Usa
    German21622130001
    BROOM, Michael Gerard
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander68759080002
    CAMPBELL-SMITH, Trevor
    12 West Drive
    Cheam
    SM2 7NA Sutton
    Surrey
    Amministratore
    12 West Drive
    Cheam
    SM2 7NA Sutton
    Surrey
    British13022460001
    CRAGGS, Gerard Paul Eyre
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    SingaporeBritish73162260003
    DONNELL, Graham
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    British126686480002
    EDMONDS, Herbert, Dr
    Firbank 3 Oldfield Road
    BR1 2LE Bromley
    Kent
    Amministratore
    Firbank 3 Oldfield Road
    BR1 2LE Bromley
    Kent
    British6034580001
    EDMONDS, Philip Martin
    Spiegelbergstrasse
    Walchwil
    29d
    6318
    Switzerland
    Amministratore
    Spiegelbergstrasse
    Walchwil
    29d
    6318
    Switzerland
    SwitzerlandBritish47042780005
    FAKTOR, David Michael
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish63162780003
    GRAF, Steven Mitchell
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    UsaAmerican73398060001
    HARVEY, Ronald Vernon George
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish13505210002
    HERITAGE, Colin Hillam
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    United KingdomBritish35217320002
    JONES, Andrew Edward
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    1
    Uk
    Amministratore
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    1
    Uk
    United KingdomBritish32372760004
    LODGE, Jane Ann
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish24341880002
    OPPENHEIMER, Ralph David
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    United KingdomBritish17769520001
    OPPENHEIMER, Susan Elizabeth
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    Amministratore
    Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Citypoint One
    United KingdomBritish5478190001
    PAUL, David John
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish15574420001
    POISSON, Rene
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish189033010001
    PRYOR, Martin Thomas
    Glenhurst House The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Glenhurst House The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    British55771870001
    RICHARDSON, William Leonard
    32 Grange Road
    CM23 5NQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    32 Grange Road
    CM23 5NQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British11486520001
    ROCKER, Christopher David
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish134359300001
    STERNBERG, Helmut
    Hagedornstrasse 49
    20149 Hamburg
    Germany
    Amministratore
    Hagedornstrasse 49
    20149 Hamburg
    Germany
    German16386950001
    STOCK, Matthew Graham
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    British73092970005
    VERDEN, Julian
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9ST London
    Level 27 Citypoint
    United Kingdom
    EnglandBritish14876960005
    WALKER, Andrew John
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish51959750002
    WHITEHEAD, Paul Shaw
    Schneitstrasse 39
    6315
    4
    Oberaegeri
    Switzerland
    Amministratore
    Schneitstrasse 39
    6315
    4
    Oberaegeri
    Switzerland
    SwitzerlandNew Zealander162838450001
    WILLIAMS, Alan Ernest John
    Wood Hatch Cotchford Lane
    Upper Hartfield
    TN7 4DN Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    Wood Hatch Cotchford Lane
    Upper Hartfield
    TN7 4DN Hartfield
    East Sussex
    British18790750001
    YAO, Cho Fai Andrew
    Flat B 5/F The Somerset
    67 Repulse Bay
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    Flat B 5/F The Somerset
    67 Repulse Bay
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    Chinese74463630001

    MOORGATE INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2015
    Consegnato il 13 ott 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 13 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2015
    Consegnato il 13 ott 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Coportaion Limited (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 set 2015
    Consegnato il 15 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 15 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 ago 2015
    Consegnato il 28 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 28 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 ago 2014
    Consegnato il 05 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Icici Bank Limited
    Transazioni
    • 05 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2014
    Consegnato il 23 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa (as Common Security Agent)
    Transazioni
    • 23 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 apr 2014
    Consegnato il 28 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 apr 2014
    Consegnato il 28 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 apr 2014
    Consegnato il 29 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Citibank, N.A., Uae Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Acquisito il 03 set 2015
    Consegnato il 18 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Intellectual property. 1. UK trademark registration no 91252, "stemcor" class 06 and class 36. 2. UK trademark registration no 1088745 "every step in steel", class 6. 3. UK trademark registration no 1001755 "stemcor" class 6 and class 36. for more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 18 set 2015Registrazione di un'acquisizione (MR02)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 24 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 24 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2014
    Consegnato il 21 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of hypothecation and lien
    Creato il 04 set 2008
    Consegnato il 05 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All documents and goods and all policies of insurance relating thereto see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited
    Transazioni
    • 05 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge
    Creato il 20 nov 2006
    Consegnato il 24 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Each negotiable instrument and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited
    Transazioni
    • 24 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 23 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge and with all full title guarantee all its rights, title and interest in and to the receivables as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natexis Banques Populaires
    Transazioni
    • 23 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 23 mag 2006
    Consegnato il 07 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each assignor to the secured parties and any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in to and under all excess collateral and monetary surpluses in the form of receivables cash or otherwise held in the trust account all proceeds and all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 07 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge and fixed charge over receivables
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 20 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All reveivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 20 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge
    Creato il 27 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Each negotiable instrument and each bill of lading,warrant,delivery order,wharfinger's or other warehouse keeper's certificate or receipt.all present and future contracts,all guarantees,letters of credit, letters of indemnity or similar obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Belgolaise Bank
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General letter of pledge
    Creato il 22 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All goods which are now or shall hereafter be delivered by the company or on the companys behalf into the banks possession or into the possession of the banks agents on its behalf and upon all bills of lading dock or warehouse warrants policies of insurance delivery orders and all other document of title and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Belgolaise Sa
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge and charge
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 18 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the receivables being all present an future contracts, all guarantees letters of credit, any present or future claims any present or future wash-out book-out circle settlement netting or other similar arrangement or agreement, all present and future things in action which may give rise to any debt or claim under or pursuant to any property described above together with the full benefit of any guarantee security or other rights relating to any such property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dbs Bank Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MOORGATE INDUSTRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 ott 2015Inizio dell'amministrazione
    03 ott 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Anthony Victor Lomas
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DataTipo
    17 set 2018Data della petizione
    03 ott 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Phillip Rodney Sykes
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0