ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED
Panoramica
Nome della società | ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01038578 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
- Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione
Dove si trova ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Ship Canal House 8th Floor 98 King Street M2 4WB Manchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EMAP ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED | 29 dic 1988 | 29 dic 1988 |
EMAP HEIGHWAY LIMITED | 16 set 1988 | 16 set 1988 |
REES PUBLISHING COMPANY LIMITED | 29 ott 1986 | 29 ott 1986 |
REES HOLIDAYS LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
REES EDUCATIONAL TRAVEL CONSULTANTS LIMITED | 17 gen 1972 | 17 gen 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione | 49 pagine | AM23 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 17 mar 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 56 pagine | AM10 | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 5 pagine | AM19 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 57 pagine | AM10 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Guy Butterworth come amministratore in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Michael Mccall come segretario in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John King come amministratore in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 6 pagine | AM06 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG a Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB in data 10 dic 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 123 pagine | AM03 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 5 pagine | AM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2017 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Guy Butterworth come amministratore in data 24 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore in data 05 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 gen 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Parkinson come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Kings Road Bury St Edmunds Suffolk IP33 3ET a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG in data 06 ago 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 gen 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDS, David | Segretario | 76 Elm Road Folksworth PE7 3SX Peterborough Cambridgeshire | English | 44306690001 | ||||||
HUNT, Stephen John Ernest | Segretario | 18 Ely Close IP33 2NA Bury St Edmunds Suffolk | British | 103509010001 | ||||||
MCCALL, Peter Michael | Segretario | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 161445610001 | |||||||
SMITH, David Paul | Segretario | Brookfields Station Road PE7 3PH Holme Peterborough | British | Finance Director | 39237320003 | |||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
ALLEN, Frederick John | Amministratore | 6 Glebe Close Horringer IP29 5PR Bury St Edmunds Suffolk | British | Publisher | 30121880001 | |||||
ALLEN, Frederick John | Amministratore | 6 Glebe Close Horringer IP29 5PR Bury St Edmunds Suffolk | British | Managing Director | 30121880001 | |||||
BAILLIE, John Andrew Main | Amministratore | Yew Cottage Main Road, Uffington PE9 4SN Stamford Lincolnshire | British | Company Director | 76483990001 | |||||
BOWDLER, Timothy John | Amministratore | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | Newspaper Director | 37521870002 | ||||
BUTTERWORTH, Michael Guy | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | England | British | Chartered Accountant | 76600500002 | ||||
CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Amministratore | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | Financial Director | 474360001 | ||||
CURRY, Anthony Benjamin | Amministratore | 33 Lynn Road Dersingham PE31 6JY Kings Lynn Norfolk | British | Company Director | 34157260001 | |||||
DAINTY, Christopher | Amministratore | Hillside House Gumley LE16 7RU Market Harborough Leics | British | Publisher | 32406580001 | |||||
DAVISON YOUNG, Amanda | Amministratore | Station Lodge Beamish DH9 0QX Stanley County Durham | United Kingdom | British | Managing Director | 119655320001 | ||||
DIXON, David Andrew | Amministratore | 13 Sandover Close West Winch PE33 0JZ Kings Lynn Norfolk | United Kingdom | English | Publisher | 30121900002 | ||||
DIXON, David Andrew | Amministratore | 13 Sandover Close West Winch PE33 0JZ Kings Lynn Norfolk | United Kingdom | English | Director Of Companies | 30121900002 | ||||
FEETHAM, Robert Anthony | Amministratore | 4 The Charters Uffington PE9 4UD Stamford Lincolnshire | England | British | Publisher | 64401770001 | ||||
FRY, John Anthony | Amministratore | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | Chief Executive | 136914890001 | ||||
HANDS, David | Amministratore | 76 Elm Road Folksworth PE7 3SX Peterborough Cambridgeshire | England | English | Accountant | 44306690001 | ||||
HANDS, David | Amministratore | 76 Elm Road Folksworth PE7 3SX Peterborough Cambridgeshire | England | English | Finance Director | 44306690001 | ||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
HOXLEY, Peter William | Amministratore | 9 Sebert Road IP32 7EB Bury St Edmunds Suffolk | England | British | Advertisement Manager | 30121910002 | ||||
HUTTON, Wayne | Amministratore | 11 Ouse Walk PE29 3QL Huntingdon | United Kingdom | British | Managing Director | 72646360005 | ||||
JOHNSTON, Frederick Patrick Mair | Amministratore | 1 Grange Terrace EH9 2LD Edinburgh | British | Company Director | 328390001 | |||||
KING, David John | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
LANKESTER, David Robin Archibald | Amministratore | 11 Bath Row PE9 2QU Stamford Lincolnshire | British | Director Of Companies | 49804010002 | |||||
MURRAY, Grant | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
PARKINSON, Richard | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | England | British | Managing Director | 103967630001 | ||||
PARKINSON, Richard | Amministratore | Staples House Staples Court Great Ponton NG33 5DZ Grantham Lincolnshire | England | British | Managing Director | 103967630001 | ||||
PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 64281400001 | ||||
PENNOCK, Christopher John | Amministratore | Manor Barn, Main Street Greatford PE9 4QA Stamford Lincolnshire | Uk | British | Group Md | 79702280001 | ||||
REWSE-DAVIES, Jason | Amministratore | c/o C/O Johnston Press Plc Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 132415800001 | ||||
SAYERS, Elizabeth Mary | Amministratore | Rosewood House Woodditton Road CB8 9BQ Newmarket Suffolk | British | Director Of Companies | 21301590001 | |||||
SCOTT, Malcolm Bowers | Amministratore | 90 Gayton Road PE30 4ER Kings Lynn Norfolk | British | Director | 29994110002 | |||||
STONE, Margaret Anne | Amministratore | 13 Church Crofts Castle Rising PE31 6BG King`S Lynn Norfolk | British | Advertisement Director | 44239450001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnston Press Plc | 06 apr 2016 | 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 23 giu 2014 Consegnato il 01 lug 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Part limes house purfleet street kings lynn t/no NK124026, newspaper titles: bury free press and suffolk free press please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession | Creato il 25 set 2009 Consegnato il 30 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 lug 1996 Consegnato il 19 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations") | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0