ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED

ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANGLIA NEWSPAPERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01038578
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    • Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EMAP ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED29 dic 198829 dic 1988
    EMAP HEIGHWAY LIMITED16 set 198816 set 1988
    REES PUBLISHING COMPANY LIMITED 29 ott 198629 ott 1986
    REES HOLIDAYS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    REES EDUCATIONAL TRAVEL CONSULTANTS LIMITED17 gen 197217 gen 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    49 pagineAM23

    Indirizzo della sede legale modificato da Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 17 mar 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    56 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    5 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    57 pagineAM10

    Cessazione della carica di Michael Guy Butterworth come amministratore in data 17 mag 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Michael Mccall come segretario in data 17 mag 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David John King come amministratore in data 17 mag 2019

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    6 pagineAM06

    Indirizzo della sede legale modificato da Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG a Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB in data 10 dic 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    123 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    5 pagineAM01

    Bilancio redatto al 30 dic 2017

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Guy Butterworth come amministratore in data 24 set 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore in data 05 giu 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 02 gen 2016

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Parkinson come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ago 2015

    Stato del capitale al 07 ago 2015

    • Capitale: GBP 30,100
    • Capitale: USD .01
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Kings Road Bury St Edmunds Suffolk IP33 3ET a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG in data 06 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 03 gen 2015

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANDS, David
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    English44306690001
    HUNT, Stephen John Ernest
    18 Ely Close
    IP33 2NA Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    18 Ely Close
    IP33 2NA Bury St Edmunds
    Suffolk
    British103509010001
    MCCALL, Peter Michael
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Segretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    161445610001
    SMITH, David Paul
    Brookfields
    Station Road
    PE7 3PH Holme
    Peterborough
    Segretario
    Brookfields
    Station Road
    PE7 3PH Holme
    Peterborough
    BritishFinance Director39237320003
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    Segretario
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    British16754910001
    ALLEN, Frederick John
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishPublisher30121880001
    ALLEN, Frederick John
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishManaging Director30121880001
    BAILLIE, John Andrew Main
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    BritishCompany Director76483990001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Amministratore
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishNewspaper Director37521870002
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritishChartered Accountant76600500002
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Amministratore
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritishFinancial Director474360001
    CURRY, Anthony Benjamin
    33 Lynn Road
    Dersingham
    PE31 6JY Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    33 Lynn Road
    Dersingham
    PE31 6JY Kings Lynn
    Norfolk
    BritishCompany Director34157260001
    DAINTY, Christopher
    Hillside House
    Gumley
    LE16 7RU Market Harborough
    Leics
    Amministratore
    Hillside House
    Gumley
    LE16 7RU Market Harborough
    Leics
    BritishPublisher32406580001
    DAVISON YOUNG, Amanda
    Station Lodge
    Beamish
    DH9 0QX Stanley
    County Durham
    Amministratore
    Station Lodge
    Beamish
    DH9 0QX Stanley
    County Durham
    United KingdomBritishManaging Director119655320001
    DIXON, David Andrew
    13 Sandover Close
    West Winch
    PE33 0JZ Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    13 Sandover Close
    West Winch
    PE33 0JZ Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomEnglishPublisher30121900002
    DIXON, David Andrew
    13 Sandover Close
    West Winch
    PE33 0JZ Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    13 Sandover Close
    West Winch
    PE33 0JZ Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomEnglishDirector Of Companies30121900002
    FEETHAM, Robert Anthony
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritishPublisher64401770001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Amministratore
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishChief Executive136914890001
    HANDS, David
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandEnglishAccountant44306690001
    HANDS, David
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    76 Elm Road
    Folksworth
    PE7 3SX Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandEnglishFinance Director44306690001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    HOXLEY, Peter William
    9 Sebert Road
    IP32 7EB Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    9 Sebert Road
    IP32 7EB Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishAdvertisement Manager30121910002
    HUTTON, Wayne
    11 Ouse Walk
    PE29 3QL Huntingdon
    Amministratore
    11 Ouse Walk
    PE29 3QL Huntingdon
    United KingdomBritishManaging Director72646360005
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    Amministratore
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    BritishCompany Director328390001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    LANKESTER, David Robin Archibald
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    BritishDirector Of Companies49804010002
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    PARKINSON, Richard
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritishManaging Director103967630001
    PARKINSON, Richard
    Staples House Staples Court
    Great Ponton
    NG33 5DZ Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Staples House Staples Court
    Great Ponton
    NG33 5DZ Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritishManaging Director103967630001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    PENNOCK, Christopher John
    Manor Barn, Main Street
    Greatford
    PE9 4QA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Manor Barn, Main Street
    Greatford
    PE9 4QA Stamford
    Lincolnshire
    UkBritishGroup Md79702280001
    REWSE-DAVIES, Jason
    c/o C/O Johnston Press Plc
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Johnston Press Plc
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132415800001
    SAYERS, Elizabeth Mary
    Rosewood House
    Woodditton Road
    CB8 9BQ Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Rosewood House
    Woodditton Road
    CB8 9BQ Newmarket
    Suffolk
    BritishDirector Of Companies21301590001
    SCOTT, Malcolm Bowers
    90 Gayton Road
    PE30 4ER Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    90 Gayton Road
    PE30 4ER Kings Lynn
    Norfolk
    BritishDirector29994110002
    STONE, Margaret Anne
    13 Church Crofts
    Castle Rising
    PE31 6BG King`S Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    13 Church Crofts
    Castle Rising
    PE31 6BG King`S Lynn
    Norfolk
    BritishAdvertisement Director44239450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Johnston Press Plc
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    06 apr 2016
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc015382
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 giu 2014
    Consegnato il 01 lug 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Part limes house purfleet street kings lynn t/no NK124026, newspaper titles: bury free press and suffolk free press please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 01 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of accession
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 30 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1996
    Consegnato il 19 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations")
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Trustee for and on Behalf Ofthe Agent, the Banks and Rbs)
    Transazioni
    • 19 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ANGLIA NEWSPAPERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ago 2020Fine dell'amministrazione
    17 nov 2018Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0