JBMHL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJBMHL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01043129
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JBMHL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova JBMHL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JBMHL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JBM HOLDINGS LIMITED01 giu 199401 giu 1994
    J.B.M. ELECTRICAL DISTRIBUTORS LIMITED31 dic 197731 dic 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di JBMHL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JBMHL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per JBMHL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 1 Tatton Street Knutsford Cheshire WA16 6AY a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 11 giu 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 mag 2015

    LRESSP

    Memorandum e Statuto

    5 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    Restriction of share capital removed/ 31/12/2014
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 gen 2015

    • Capitale: GBP 234,993
    4 pagineSH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed jbm holdings LIMITED\certificate issued on 17/03/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name17 mar 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 05 mar 2015

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2014

    Stato del capitale al 26 giu 2014

    • Capitale: GBP 167,750
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di JBMHL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELSEGOOD, Philip Graham
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Segretario
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    British22304520002
    GODDARD, Roger David
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    United KingdomBritish83553400001
    MCNAIR, Douglas Talbot
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    United KingdomBritish855740001
    COCKROFT, Richard Martin
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    Segretario
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    British31450950001
    MONKS, John Byron
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Segretario
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British13594610001
    BALLANTYNE, Ronald Young
    Westway Albert Square
    Bowdon
    WA14 2ND Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Westway Albert Square
    Bowdon
    WA14 2ND Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish855730001
    BENTON, Brian William
    Forest Borders
    Chapel Lane
    SO41 6BS Sway Lymington
    Hants
    Amministratore
    Forest Borders
    Chapel Lane
    SO41 6BS Sway Lymington
    Hants
    British31450960001
    COCKROFT, Richard Martin
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    British31450950001
    MONKS, Christopher Maurice
    6 Montfort Close
    SO51 5PH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    6 Montfort Close
    SO51 5PH Romsey
    Hampshire
    British38341280001
    MONKS, John Byron
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British13594610001
    MONKS, John Laurence
    Nursery Farm Cottage
    Stock Lane, Landford
    SP5 2ER Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Nursery Farm Cottage
    Stock Lane, Landford
    SP5 2ER Salisbury
    Wiltshire
    British65758480001
    SAVAGE, Edward James
    Chelidon Crossway
    Southdown Shawford
    SO21 2BT Winchester
    Hants
    Amministratore
    Chelidon Crossway
    Southdown Shawford
    SO21 2BT Winchester
    Hants
    British13594620001

    JBMHL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1990
    Consegnato il 08 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 11 towergate industrial park colebrook way andover hampshire together with all buildings, erections & fixtures (other than trade machinery as defined).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge supplemental to a mortgage debentutre dated 19-7-77.
    Creato il 10 ago 1989
    Consegnato il 15 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with national westminster bank PLC all monies which it may receive in respect of all book and other debts hereby charged by any other existing or future charge and shall not without consent in writing by nat. West. Bank PLC sellfactor discount or charge or assign the same in favour of any other person and the company shall if called upon to do by nat. West. Bank PLC execute legal assignments of such book and other debts to the national westminster bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1988
    Consegnato il 05 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, unit 11 tower gate industrial park, weyhill road, andover, hampshire with all buildings and erections and all fixtures (other than trade machinery).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC.
    Transazioni
    • 05 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 03 apr 1987
    Consegnato il 13 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unicorn house princes street northam southampton hampshire title no hp 240245 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 lug 1977
    Consegnato il 28 lug 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all the company's estate or interest in all freehold and leasehold properties, all stock shares and other securites. All book debts and other debts, assignment of goodwill, a floating charge over undertaking all other property and assets present and future (please see doc M10).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 04 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    JBMHL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 mag 2015Inizio della liquidazione
    14 apr 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0