BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED

BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01044596
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    England And Wales
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILTON HOUSE INVESTMENTS LIMITED02 mar 197202 mar 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham England and Wales TN16 1RG United Kingdom in data 28 nov 2011

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve entry into an agreement 26/07/2011
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve a transfer by the company 26/07/2011
    RES13

    Cessazione della carica di Mark Stephen Mitchell come amministratore in data 14 nov 2011

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ashley House Ashley Road Epsom Surrey KT18 5AZ in data 14 nov 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2011

    Stato del capitale al 08 lug 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Stephen Jeremy Hirst come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mark Stephen Mitchell come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Johnson come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147807930001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    HIRST, Stephen Jeremy
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    Amministratore
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    United KingdomBritish95787000001
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    GODFREY, Nicholas Joseph
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    Segretario
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    British89433450001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    NORTH, Stephen William
    2 Warren Close
    Woodsetts
    S81 8SL Worksop
    Nottinghamshire
    Segretario
    2 Warren Close
    Woodsetts
    S81 8SL Worksop
    Nottinghamshire
    British13214120002
    ROBINSON, Ian
    82 Hunter Hill Road
    Hunters Bar
    S11 8UE Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    82 Hunter Hill Road
    Hunters Bar
    S11 8UE Sheffield
    South Yorkshire
    British53017060001
    RUSSELL, Paul Anthony
    Copperbeach
    Stripe Road, Rossington
    DN11 0EY Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Copperbeach
    Stripe Road, Rossington
    DN11 0EY Doncaster
    South Yorkshire
    British1965480002
    WAINWRIGHT, Robert Walter
    Kings Close Lindrick Lane
    Tickhill
    DN11 9RA Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Kings Close Lindrick Lane
    Tickhill
    DN11 9RA Doncaster
    South Yorkshire
    British1965490001
    WILSON, Mark William
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    18 Silverdale Close
    Ecclesall
    S11 9JN Sheffield
    South Yorkshire
    British78419380001
    BAILEY, Benjamin Richard
    Milton House
    Church Street
    S64 0HG Mexborough
    South Yorkshire
    Amministratore
    Milton House
    Church Street
    S64 0HG Mexborough
    South Yorkshire
    United KingdomBritish1965520001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DRABBLE, Peter
    5 Church Lane
    Old Ravenfield
    Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    5 Church Lane
    Old Ravenfield
    Rotherham
    South Yorkshire
    British35736830001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GODFREY, Nicholas Joseph
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    Amministratore
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    United KingdomBritish89433450001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MITCHELL, Mark Stephen
    Snaithing Heights
    Clumber Road, Ranmoor
    S10 3LE Sheffield
    37
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Snaithing Heights
    Clumber Road, Ranmoor
    S10 3LE Sheffield
    37
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish116693280003
    WAINWRIGHT, Robert Walter
    Kings Close Lindrick Lane
    Tickhill
    DN11 9RA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Kings Close Lindrick Lane
    Tickhill
    DN11 9RA Doncaster
    South Yorkshire
    British1965490001

    BEN BAILEY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A bond and floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 ago 2007
    Consegnato il 04 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a pastures road mexborough t/n SYK268775 and SYK268776. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2007
    Consegnato il 25 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 28 mag 1991
    Consegnato il 04 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north of pasture road, mexborough, south yorkshire. Title no:- syk 268776 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 gen 1989
    Consegnato il 06 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at pastures road mexborough, south yorkshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 apr 1986
    Consegnato il 10 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge on the company's f/h and l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage & further charge
    Creato il 22 feb 1985
    Consegnato il 12 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 12 sep 1974
    Brevi particolari
    F/H old land k/a elizabeth house cliff street, mexborough doncaster, south yorkshire. Title no. Syk 19069 and land having a frontage to church street mexborough, doncaster, south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 mag 1982
    Consegnato il 21 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory/warehouse buildings and 5 lock up shops known as ward's brewery, swinton rotherham south yorkshire. Title nos syk 114667, syk 24766, syk 40173, syk 89616 and syk 116337. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage & further charge
    Creato il 20 mar 1981
    Consegnato il 25 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000 due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H property having a frontage to church st, mexborough, south yorkshire and industrial premises at west side of denby way, hellaby, rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1976
    Consegnato il 14 set 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of cliff street, mexborough, doncaster, south yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 set 1974
    Consegnato il 13 set 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing 16,650 and all monies due or to become due from the company and housecraft mexborough LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property church street mexborough yorkshire conveyance dated 29/9/73.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance LTD
    Transazioni
    • 13 set 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0