HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED

HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHIFLEX FLUIDPOWER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01046614
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNLOP HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED17 gen 199617 gen 1996
    DUNLOP HIFLEX DISTRIBUTION LIMITED14 ago 198614 ago 1986
    HI-FLEX DISTRIBUTION LIMITED17 mar 197217 mar 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 feb 2011

    12 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 08 feb 2011

    12 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 ago 2010

    11 pagine2.24B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    11 pagine2.39B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 feb 2010

    12 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 ago 2009

    11 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 feb 2009

    15 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    70 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    44 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    67 pagine2.17B

    legacy

    2 pagine403a

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIRD, Robert Nigel
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    British102415230002
    BIRD, Robert Nigel
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritish102415230002
    GREEN, Guy Brent
    57 Devises Road
    SP2 7LQ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    57 Devises Road
    SP2 7LQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish127398500001
    OLDHAM, David Howard
    10 Lyneham Farm Cottages
    OX7 6QP Lyneham
    Oxfordshire
    Amministratore
    10 Lyneham Farm Cottages
    OX7 6QP Lyneham
    Oxfordshire
    United KingdomBritish125105960001
    BOLTON, Sean James Southward
    26 Colchester Avenue
    LA1 4AX Lancaster
    Lancashire
    Segretario
    26 Colchester Avenue
    LA1 4AX Lancaster
    Lancashire
    British97825540001
    MINICK, Woodrow Ted
    2433 Thomas Drive 159
    32408 Panama City
    Florida
    Usa
    Segretario
    2433 Thomas Drive 159
    32408 Panama City
    Florida
    Usa
    American55856920009
    TAWTON, Gerald John
    216 Sleaford Road
    PE21 7PG Boston
    Lincolnshire
    Segretario
    216 Sleaford Road
    PE21 7PG Boston
    Lincolnshire
    British107160500001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Segretario
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    BEESLEY, Michael John
    Hillside House Fir Tree Hill
    Alderholt
    SP6 3AY Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Hillside House Fir Tree Hill
    Alderholt
    SP6 3AY Fordingbridge
    Hampshire
    British56928540001
    BOLTON, Sean James Southward
    26 Colchester Avenue
    LA1 4AX Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    26 Colchester Avenue
    LA1 4AX Lancaster
    Lancashire
    British97825540001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    British6343100001
    BURGIN, Clifford Mark
    Kynance Harewood Road
    LS22 5BZ Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kynance Harewood Road
    LS22 5BZ Collingham
    West Yorkshire
    EnglandBritish98263080001
    BURGIN, Clifford Mark
    Kynance Harewood Road
    LS22 5BZ Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kynance Harewood Road
    LS22 5BZ Collingham
    West Yorkshire
    EnglandBritish98263080001
    CANT, Laurence
    26 Grosvenor Close
    Ashley Heath
    BH24 2HG Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    26 Grosvenor Close
    Ashley Heath
    BH24 2HG Ringwood
    Hampshire
    British2306360001
    CROWE, Daniel Kenneth
    28 Fosters Bushes
    Amesbury
    SP4 7SG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    28 Fosters Bushes
    Amesbury
    SP4 7SG Salisbury
    Wiltshire
    British126814430001
    HARRISON, John Robert
    Scatterbrook
    Sandleheath
    SP6 1PL Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Scatterbrook
    Sandleheath
    SP6 1PL Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish61565220001
    LEWIS, Karen Joyce
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    39 Wychwood Grove
    Chandlers Ford
    SO53 1FQ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish127170900001
    MARSDEN, Simon
    Woodbourne
    Ling Line Scarcroft
    LS14 3HB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodbourne
    Ling Line Scarcroft
    LS14 3HB Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish181813280001
    PARRATT, Christopher Joseph
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    British83226780001
    QUICKFALL, Garry Charles
    20 Norhurst
    Whickham
    NE16 5UX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    20 Norhurst
    Whickham
    NE16 5UX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish109726490001
    STEARNES, Clive James
    8 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    8 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Surrey
    British6957720001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Amministratore
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TEACHER, Michael John
    18 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    18 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish25420830001
    THOM, James Demmink
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    Amministratore
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    British38683120002
    VLACHOJANNIS, Georg
    Steinstr 33a
    Buehl
    Barden-Wurtenberg D-77815
    Germany
    Amministratore
    Steinstr 33a
    Buehl
    Barden-Wurtenberg D-77815
    Germany
    German126813990001
    WHITEHEAD, Peter
    The Paddock
    The Green Low Worsall
    TS15 9PJ Yarm
    Yorkshire
    Amministratore
    The Paddock
    The Green Low Worsall
    TS15 9PJ Yarm
    Yorkshire
    EnglandBritish95780250001
    WILLARD, Veronica
    10 Lyneham Farm Cottages
    Lyneham
    OX7 6QP Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    10 Lyneham Farm Cottages
    Lyneham
    OX7 6QP Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish126814160001

    HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 07 ago 2006
    Consegnato il 16 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    £3,562.50 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The sum of £3,562.50.
    Persone aventi diritto
    • Cannon Tool Hire Limited
    Transazioni
    • 16 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 set 2005
    Consegnato il 17 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage all the estate and interest of the company in the l/h property located in england and wales together with all buildings on,and the proceeds of sale of,such property,fixed charge all fixtures (including trade fixtures,tenant's fixtures and fixed plant and machinery),all collateral rights,all securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Farington Property Company Limited
    Transazioni
    • 17 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 22 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2005
    Consegnato il 11 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 01 giu 2004
    Consegnato il 03 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH june 1999 and
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 05 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each and every liability which the company may have to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder
    Brevi particolari
    Assignments,fixed and floating charges.fixed charges (I) land the real property; (ii) tangible moveable property; (iii) accounts with the bank as security agent; (v) intellectual property; (vi) goodwill.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Fuji Bank,Limitedas Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HIFLEX FLUIDPOWER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 ago 2008Inizio dell'amministrazione
    08 feb 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zelf Hussain
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    David James Bennett
    Pricewaterhousecoopers Llp
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Gillian Eleanor Bruce
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0