STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED

STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01049020
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    • (6523) /

    Dove si trova STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIRST INTERSTATE CAPITAL MARKETS LIMITED01 lug 198501 lug 1985
    FIRST INTERSTATE LIMITED01 ago 198401 ago 1984
    CONTINENTAL ILLINOIS LIMITED10 apr 197210 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Barbara Anne Mcall come amministratore in data 03 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2018

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2017

    11 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    10 pagineLIQ10

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2016

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2015

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2014

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2013

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2012

    11 pagine4.68

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Aldermanbury Square London EC2V 7SB* in data 05 gen 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Cessazione della carica di Terry Skippen come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sandeep Jain come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2011

    Stato del capitale al 24 feb 2011

    • Capitale: GBP 8,000,000
    • Capitale: USD 4,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SC (SECRETARIES) LIMITED
    1 Aldermanbury Square
    EC2V 7SB London
    Segretario
    1 Aldermanbury Square
    EC2V 7SB London
    126490730001
    SNOW, Averina Anita
    59 Spencer Road
    TW2 5TG Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    59 Spencer Road
    TW2 5TG Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish67192720001
    BENTLEY, Gordon Andrew
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    British43125610002
    EDWARDS, Alan Charles
    20 Gwendale
    Pinkneys Green
    SL6 6SH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    20 Gwendale
    Pinkneys Green
    SL6 6SH Maidenhead
    Berkshire
    British8344980001
    SAYERS, Ian Lawrence
    Flat 1
    78 Gloucester Street
    SW1V 4EE London
    Segretario
    Flat 1
    78 Gloucester Street
    SW1V 4EE London
    British35881830001
    SKIPPEN, Terry Charles
    61 Richmond Road
    Leytonstone
    E11 4BX London
    Segretario
    61 Richmond Road
    Leytonstone
    E11 4BX London
    British54597200001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    Segretario
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    British87931760001
    BAMFORD, Julie
    18 Abbey Road
    EX4 7BG Exeter
    Devon
    Amministratore
    18 Abbey Road
    EX4 7BG Exeter
    Devon
    EnglandBritish53637130001
    BENTLEY, Gordon Andrew
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish43125610002
    BENTLEY, Gordon Andrew
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish43125610002
    BINKS, Thomas Anthony
    Fernden Grange
    Fernden Lane
    GU27 3LA Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Fernden Grange
    Fernden Lane
    GU27 3LA Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish68990910001
    BOGAARD, William Joseph
    311 Congress Place
    91105 Pasadena
    California
    Usa
    Amministratore
    311 Congress Place
    91105 Pasadena
    California
    Usa
    American36102460001
    BRIMACOMBE, David John
    Edlins
    Aston Upthorpe
    OX11 9EF Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    Edlins
    Aston Upthorpe
    OX11 9EF Didcot
    Oxfordshire
    British88602930001
    BROWN, Charles Bennett
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    Amministratore
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    British107840600001
    CASTLEMAN, Christopher Norman Anthony
    182 Kensington Park Road
    W11 2ER London
    Amministratore
    182 Kensington Park Road
    W11 2ER London
    British11677630001
    CRAVER, Theodore Frankton
    1219 Villa Wood
    FOREIGN Pacific Palisades
    California 90272
    Usa
    Amministratore
    1219 Villa Wood
    FOREIGN Pacific Palisades
    California 90272
    Usa
    Us8345000001
    DOOMEY, William John
    24214 West Oakvale Drive
    FOREIGN Valencia
    California 91355
    Usa
    Amministratore
    24214 West Oakvale Drive
    FOREIGN Valencia
    California 91355
    Usa
    Us8345030001
    HARRIS, John Duncan
    The Green
    Easton
    SO21 1EG Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Green
    Easton
    SO21 1EG Winchester
    Hampshire
    British8345040001
    HARVEY, Deborah
    Euronext Liffe Cannon Bridge House
    1 Cousin Lane
    EC4R 3XX London
    Amministratore
    Euronext Liffe Cannon Bridge House
    1 Cousin Lane
    EC4R 3XX London
    British62614370002
    HAYMAN, Martin Heathcote
    12 Brookfield Park
    NW5 1ER London
    Amministratore
    12 Brookfield Park
    NW5 1ER London
    EnglandBritish5900650001
    JAIN, Sandeep Kumar
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomIndian154448750001
    LINDEMANN, Jurgen Heinrich
    Bel Air Birch Hill
    CR0 5HT Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Bel Air Birch Hill
    CR0 5HT Croydon
    Surrey
    German8345010001
    LOCKERBIE, Iain Jardine
    63 Trematon Place
    TW11 9RH Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    63 Trematon Place
    TW11 9RH Teddington
    Middlesex
    British62993140001
    LORD, David Gerald
    30 Old Park Avenue
    SW12 8RH London
    Amministratore
    30 Old Park Avenue
    SW12 8RH London
    British8345020001
    MAULE, Peter Allen
    Ashby House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ashby House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    British8133160001
    MCALL, Barbara Anne
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish147969860019
    MCDONALD, William Baxter
    Lanterns Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lanterns Beacon Hill
    Penn
    HP10 8NH High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish47113270001
    MCGURRAN, John Thomas
    10 Church Field
    CM16 4RF Epping
    Essex
    Amministratore
    10 Church Field
    CM16 4RF Epping
    Essex
    British8345050001
    MEYERMAN, Harold John
    935 Hillcrest Place
    FOREIGN Pasadena
    California 91106
    Usa
    Amministratore
    935 Hillcrest Place
    FOREIGN Pasadena
    California 91106
    Usa
    Us8345060001
    NORTHWAY, Mark Alastair
    22 Wyleu Street
    Forest Hill
    SE23 1DU London
    Amministratore
    22 Wyleu Street
    Forest Hill
    SE23 1DU London
    British8345070001
    O DRISCOLL, Conor Francis
    47 Iverna Court
    Kensington
    W8 6TS London
    Amministratore
    47 Iverna Court
    Kensington
    W8 6TS London
    Irish40951760002
    PRIEST, Robin Andrew
    35 Portland Road
    W11 4LH London
    Amministratore
    35 Portland Road
    W11 4LH London
    British74218060001
    REES, Alun Michael Guest
    11 Portmore Quays
    Portmore Park Road
    KT13 8HF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    11 Portmore Quays
    Portmore Park Road
    KT13 8HF Weybridge
    Surrey
    British32456990001
    ROBERTS, Peter John
    7 Laurel Grove
    Kingswood
    ME17 3PS Maidstone
    Kent
    Amministratore
    7 Laurel Grove
    Kingswood
    ME17 3PS Maidstone
    Kent
    EnglandBritish50230490001
    SHANAHAN, Francis Patrick
    8 Weybridge Court
    FOREIGN Newport Beach
    California 92660
    Usa
    Amministratore
    8 Weybridge Court
    FOREIGN Newport Beach
    California 92660
    Usa
    Us8345090001

    STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Custody agreement
    Creato il 11 apr 1994
    Consegnato il 21 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All the cash from time to time in the cash account, all the shares stocks bonds notes debentures or other securities held from time to time for the account of "standard chartered capital markets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust of New York
    Transazioni
    • 21 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Direct custody agreement
    Creato il 18 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under theterms of the direct custody agreement.
    Brevi particolari
    To the extent permitted by applicable law, the client hereby(i) pledges to the custodian a security for the paymment of the fees and other amounts referred to in section X111 as well as any other obligation or liability of any kind which the client may have to the custodian in connection with this agreement,all amounts received from time to time and all securities held by the custodian,a subcustodian or a securities depository (see relevant form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York.
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collateral agreement
    Creato il 04 mag 1989
    Consegnato il 10 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See form 395 ref: M181 for full details of charge.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 10 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over securities
    Creato il 17 ott 1984
    Consegnato il 23 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (A) sterling pounds 1,000,000 principal amount of acona N.V. 14 percent. Guaranteed bonds 1985 (the "bonds")., (B) all the rights the company may now or hereafter have as against euro-clear clearance system PLC ("euro-clear") to require euro-clear to deliver the bonds to it, (c) such stocks, shares, bonds, notes or other securities or the certificates for which are new or may at any time hereafter be deposited with cinb in accordance with clause 3(a) or otherwise for the purpose of the charge.
    Persone aventi diritto
    • First Interstate Banks of California.
    Transazioni
    • 23 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge over securities
    Creato il 03 feb 1983
    Consegnato il 23 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (A) £1,000,000 principal amount of acona N.V. 14 per cent. Guaranteed bonds 1985 (the "bonds")., (B) all the rights the company may now or hereafter have as against euro-clear clearance system PLC ("euro-clear") to require euro-clear to deliver the bonds to it, (c) such stocks shares bonds notes or the certificates for which are now or may at any time hereafter be deposited with cinb in accordance with clause 3(a) or otherwise for the purpose of the charge.
    Persone aventi diritto
    • Continental Illinois National Banks and Trust Company of Chicago.
    Transazioni
    • 23 feb 1983Registrazione di un'ipoteca

    STANDARD CHARTERED CAPITAL MARKETS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 dic 2011Inizio della liquidazione
    16 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0