YOUTH WITH A MISSION LIMITED

YOUTH WITH A MISSION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYOUTH WITH A MISSION LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 01049516
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    • Attività di organizzazioni religiose (94910) / Altre attività di servizi

    Dove si trova YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al14 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mr Edwin Ronald Fillies come amministratore in data 06 gen 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Giacomma Coghi Vargas come amministratore in data 18 mar 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Matthew Braithwaite come amministratore in data 18 feb 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2023

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2022

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2021

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2020

    30 pagineAA

    Nomina di Mr Philip James Leage come amministratore in data 15 giu 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Lynn Green come amministratore in data 15 giu 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Charles Mayers come amministratore in data 30 set 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Carl Tinnion come amministratore in data 16 apr 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Anthony Simon Venning come amministratore in data 09 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2019

    32 pagineAA

    Cessazione della carica di Jemimah Alianore Wright come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edwina Clare Waddell come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dale Frederick Lambert come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Elliot Irwin Clark come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2018

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 ago 2017

    28 pagineAAMD

    Chi sono gli amministratori di YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Henry Benwell
    42 Wordsworth Road
    AL5 4AF Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    42 Wordsworth Road
    AL5 4AF Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomEnglishChartered Surveyor12325980001
    FILLIES, Edwin Ronald
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    South AfricaSouth AfricanDirector333037430001
    GONG, Yingli
    6 Highfield Oval
    AL5 4BX Harpenden
    The Clock Building
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    6 Highfield Oval
    AL5 4BX Harpenden
    The Clock Building
    Hertfordshire
    England
    EnglandChineseChartered Certified Accountant219112040002
    GREEN, Lynn
    1 Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCharity Missions99695930001
    GREEN, Michael Lynn
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    EnglandBritishCompany Director274853290001
    LEAGE, Philip James
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    EnglandBritishCharity Worker192626290001
    VARGAS, Giacomma Coghi
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Costa RicaItalianCharity Director328439630001
    HOWARD, Ila
    4 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    British77546640001
    PAYNE, Richard Anthony
    Turners Close
    AL5 5HY Harpenden
    2
    Hertfordshire
    Segretario
    Turners Close
    AL5 5HY Harpenden
    2
    Hertfordshire
    British27766240002
    ROBB, Kenneth Edward
    7 Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Hertfordshire
    British48400940001
    SHARP, Stephen Daniel
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Segretario
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    BritishAccountant115803070001
    VENING, Mark Anthony Simon
    Havard Way
    LL13 9LR Wrexham
    24
    Clwyd
    Segretario
    Havard Way
    LL13 9LR Wrexham
    24
    Clwyd
    BritishCharity Missions129009180001
    AUSTIN, Barry Dennis Keith
    Kings Lodge
    Watling Street
    CV10 0TZ Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Kings Lodge
    Watling Street
    CV10 0TZ Nuneaton
    Warwickshire
    British NzCounsellor94815800001
    AUSTIN, Barry Dennis Keith
    Kings Lodge
    Watling Street
    CV10 0TZ Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Kings Lodge
    Watling Street
    CV10 0TZ Nuneaton
    Warwickshire
    British NzCounsellor94815800001
    BRAITHWAITE, John Matthew
    Shortheath Lane
    Sulhamstead
    RG7 4EQ Reading
    The Old Post Office
    England
    Amministratore
    Shortheath Lane
    Sulhamstead
    RG7 4EQ Reading
    The Old Post Office
    England
    EnglandBritishCompany Director181514250001
    COX, Virginia Frances Elizabeth
    The Vicarage
    21 Cambridge Park
    TW1 2JE Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    The Vicarage
    21 Cambridge Park
    TW1 2JE Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishChurch Pastoral Worker45534660001
    CUNNINGHAM, Loren
    75-5851 Kuakini Highway
    Kailua-Kona
    FOREIGN Hawaii 96746
    Usa
    Amministratore
    75-5851 Kuakini Highway
    Kailua-Kona
    FOREIGN Hawaii 96746
    Usa
    American27766250001
    ELGAR, Frederick Stanton, Rev
    31 Byrefield Road
    GU2 6UB Guildford
    Surrey
    Amministratore
    31 Byrefield Road
    GU2 6UB Guildford
    Surrey
    British27766260001
    FARROW, John
    14 Rothamsted Avenue
    AL5 2DJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Rothamsted Avenue
    AL5 2DJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishRetired56467210001
    HARDY, Alan Ronald Geoffrey
    Hazells Newick Hill
    Newick
    BN8 4QR Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Hazells Newick Hill
    Newick
    BN8 4QR Lewes
    East Sussex
    BritishCompany Director9935370001
    HILL, Jennifer Margaret
    4 The Coppins
    Lisvane
    CF14 0TJ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    4 The Coppins
    Lisvane
    CF14 0TJ Cardiff
    South Glamorgan
    BritishNone118746940001
    IRWIN CLARK, Peter Elliot, Reverend
    The Vicarage
    64 Old Shoreham Road
    BN1 5DD Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    The Vicarage
    64 Old Shoreham Road
    BN1 5DD Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritishClerk In Holy Orders45534580002
    LAMBERT, Dale Frederick
    4 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Flat 2
    Hertfordshire
    Great Britain
    Amministratore
    4 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Flat 2
    Hertfordshire
    Great Britain
    EnglandBritishOperations Director178495800001
    MARKIEWICZ, Mark Leonard
    8 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Highfield Oval
    AL5 4FB Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector87322050001
    MAYERS, Stephen Charles
    De La Torre
    29130 Malaga
    Alhaurin
    Spain
    Amministratore
    De La Torre
    29130 Malaga
    Alhaurin
    Spain
    SpainBritishMissionary855890008
    MCCATHY-HILL, Justin David
    c/o Admiral Group
    Chobham Street
    LU1 3BS Luton
    Victory House
    Beds
    England
    Amministratore
    c/o Admiral Group
    Chobham Street
    LU1 3BS Luton
    Victory House
    Beds
    England
    EnglandBritishAdmiral Group81120810007
    MUIR, Iain John
    57 Ambrose Lane
    AL5 4BU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    57 Ambrose Lane
    AL5 4BU Harpenden
    Hertfordshire
    BritishMissions Director27766280001
    PALMER, Donovan Ray
    Markhams Lodge
    Wellbury Park
    SG5 3BP Hitchin
    Amministratore
    Markhams Lodge
    Wellbury Park
    SG5 3BP Hitchin
    BritishMissionary84890080002
    PAYNE, Richard Anthony
    Turners Close
    AL5 5HY Harpenden
    2
    Hertfordshire
    Amministratore
    Turners Close
    AL5 5HY Harpenden
    2
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant27766240002
    PICKFORD, David Michael
    4 Old Rectory Close
    Mersham
    TN25 6LZ Ashford
    Kent
    Amministratore
    4 Old Rectory Close
    Mersham
    TN25 6LZ Ashford
    Kent
    BritishChartered Surveyor64475900001
    PUGH-SMITH, John Edgar
    Town Farm
    Thornage
    NR25 7QF Holt
    Norfolk
    Amministratore
    Town Farm
    Thornage
    NR25 7QF Holt
    Norfolk
    United KingdomBritishBarrister101010830001
    SAUNDERSON, Fiona Tweedy
    Longacre
    Haverhill Road, Stapleford
    CB22 5BX Cambridge
    Amministratore
    Longacre
    Haverhill Road, Stapleford
    CB22 5BX Cambridge
    United KingdomBritishNone53957060002
    SHREEVES, Keir Laurence, Rev
    Town Hall Avenue
    Chiswick
    W4 5DT London
    C/O Christ Church Turnham Green
    England
    Amministratore
    Town Hall Avenue
    Chiswick
    W4 5DT London
    C/O Christ Church Turnham Green
    England
    United KingdomBritishMinister183447510002
    SINGLEHURST, Laurence Grant
    12 High Elms
    AL5 2JU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 High Elms
    AL5 2JU Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director92683890002
    TINNION, Carl
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Highfield Oval
    Ambrose Lane
    AL5 4BX Harpenden
    Herts
    United KingdomBritishDirector151808120001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per YOUTH WITH A MISSION LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    14 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    YOUTH WITH A MISSION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2017
    Consegnato il 26 mag 2017
    In corso
    Breve descrizione
    6 highfield oval harpenden AL5 4FB.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2007
    Consegnato il 10 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Highfield oval ambrose lane harpenden.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Marine mortgage
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64/64 shares in the ship next wave o/n 912753 42 metre ketch and in its appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Marine mortgage
    Creato il 26 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    £450,000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    43 metre ketch 'next wave'.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 nov 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    49 beauchamp road, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 2004
    Consegnato il 10 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    14 valnay street london,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 29 giu 2000
    Consegnato il 17 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 60 geoffrey road brockley london SE4 title number 290216. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1993
    Consegnato il 12 nov 1993
    In corso
    Importo garantito
    £500,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The kings lodge watling street higham on the hill leicestershire t/n lt 171809. 71 tresillian road lewisham london t/n ln 65612.
    Persone aventi diritto
    • John Stafford Horne
    • Richard Timothy Horneon Behalf of the Trustees of the Golden Stable Charitable Trust
    • Priscilla Ann Horne
    Transazioni
    • 12 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal morgage
    Creato il 08 ott 1993
    Consegnato il 14 ott 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property overdale 96 whittaker road derby derbyshire t/n DY241736 and proceeds of sale thereof by way of assignment the goodwill and connection of the business and the full benefit of all licences held.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 20 lug 1993
    Consegnato il 29 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property holmsted manor, cuckfield road, cuckfield, west sussex t/no. WSX6876 and the proceeds of sale thereof by way of assignment the goodwill and connection of the business and the full benefit of all licences held. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 30 apr 1993
    Consegnato il 13 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property holmsted manor cuckfield road cuckfield west sussex t/n WSX6876 and the proceeds of sale thereof an and assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 apr 1993
    Consegnato il 13 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property piece or parcel of land at ambrose lane harpenden in the county of hertfordshire k/a highfield oval harpenden and the proceeds of sale thereof and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed supplemental to a legal charge dated 15/3/93
    Creato il 15 mar 1993
    Consegnato il 23 mar 1993
    In corso
    Importo garantito
    £1,680,000 due from the comapny to the chargee supplemental to the legal charge of even date
    Brevi particolari
    All those pieces or parcels of land at ambrose lane harpenden hertford ( see 395 for full details ).
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the National Childrens Home and Orphanage
    Transazioni
    • 23 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1993
    Consegnato il 23 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreemnt dated 12/2/93
    Brevi particolari
    All those pieces or parcels of land at ambrose lane harpenden hertford (see 395 for details ).
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the National Childrens Home and Orphanage
    Transazioni
    • 23 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 gen 1992
    Consegnato il 23 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,000 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    'Spekelands' oakhill park liverpool.
    Persone aventi diritto
    • Daughters of the Heart of Mary Charitable Trustees Incorporated
    Transazioni
    • 23 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1985
    Consegnato il 06 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the kings lodge higham on the hill near nuneaton warwickshire (famerly known as lindley lodge) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0