TREND NETWORK SERVICES

TREND NETWORK SERVICES

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTREND NETWORK SERVICES
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 01049704
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TREND NETWORK SERVICES?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TREND NETWORK SERVICES?

    Indirizzo della sede legale
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TREND NETWORK SERVICES?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TREND COMMUNICATIONS LIMITED12 apr 197212 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di TREND NETWORK SERVICES?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per TREND NETWORK SERVICES?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 29 dic 2021

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Alan Smith il 16 ott 2019

    2 pagineCH01

    Notifica di Daisy Telecoms Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Daisy It Services Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019

    1 paginePSC07

    Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 29 apr 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David Lewis Mcglennon come amministratore in data 22 giu 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TREND NETWORK SERVICES?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGLENNON, David Lewis
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish181536600001
    SMITH, Stephen Alan
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish161471940001
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Segretario
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British57302660001
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Segretario
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    199438590001
    MORTON, Julia Alison
    35 Cranesbill Drive
    OX26 3WQ Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    35 Cranesbill Drive
    OX26 3WQ Bicester
    Oxfordshire
    British71324860003
    SEFTON, Michael Edward
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    British51018120001
    SHARP, Lorraine
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    Segretario
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    British26356800001
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Segretario
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    British80817560001
    SMITH, Stephen James
    16 Chiltern Ridge
    HP14 3SZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    16 Chiltern Ridge
    HP14 3SZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British10039470001
    STOKES, Reeta
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    173996330001
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    179706050001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish294355310001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    CLUTTON, Steven
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish158222570001
    COURTLEY, David John
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141213480001
    CUNNINGHAM, Hugh Patrick, Sir
    Brickyard Farm
    East Knoyle
    SP3 6BP Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Brickyard Farm
    East Knoyle
    SP3 6BP Salisbury
    Wiltshire
    British3707560001
    CURTIS, Timothy Malise
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    British10381640015
    DAVEY, Brian George
    The Hollies Handford Lane
    Yateley
    GU17 7BP Camberley
    Surrey
    Amministratore
    The Hollies Handford Lane
    Yateley
    GU17 7BP Camberley
    Surrey
    British30963350001
    FISHER, Arthur
    The Old Sun
    Brook Stones
    OX39 4LY Sydenham
    Oxford
    Amministratore
    The Old Sun
    Brook Stones
    OX39 4LY Sydenham
    Oxford
    British93317860001
    ILLA, Jordi
    Ramon Turro 93 3rd-2nd
    Barcelona
    08005
    Spain
    Amministratore
    Ramon Turro 93 3rd-2nd
    Barcelona
    08005
    Spain
    Spanish76766450001
    LALE, Jean-Pierre
    High Street
    HP23 5AH Tring
    24c
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    HP23 5AH Tring
    24c
    Herts
    United Kingdom
    French135442370001
    LANGLANDS, Alan Dickson
    17 The Glebe
    Weston Turville
    HP22 5ST Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    17 The Glebe
    Weston Turville
    HP22 5ST Aylesbury
    Buckinghamshire
    British36270170002
    MARKE, Nathan Richard
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish194292450001
    MARTIN, William Thomas
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish57302660001
    MULLER, Neil Keith
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    EnglandBritish252490400001
    NICHOLSON, Peter Frank
    18 Wainwrights
    HP18 9DT Long Crendon
    Buckinghamshire
    Amministratore
    18 Wainwrights
    HP18 9DT Long Crendon
    Buckinghamshire
    EnglandBritish242772210001
    PATERSON, Ian
    20 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UJ London
    Amministratore
    20 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UJ London
    British46186950001
    RATTRAY, Bruce Davidson
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish3071690001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish178585250001
    ROBINSON, Nicholas John
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish54873290006
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    RUSSELL, Julian Philip
    2 Shepherds Close
    OX25 3RF Weston On The Green
    Shepherds Barn
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Shepherds Close
    OX25 3RF Weston On The Green
    Shepherds Barn
    Oxfordshire
    United KingdomBritish117227890002
    SANDER, Bernhard
    Avenstr. 10
    Pfaffenhofen
    D- 852 76
    Germany
    Amministratore
    Avenstr. 10
    Pfaffenhofen
    D- 852 76
    Germany
    German39558960002
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Amministratore
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    SMITH, Stephen James
    16 Chiltern Ridge
    HP14 3SZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Chiltern Ridge
    HP14 3SZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British10039470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TREND NETWORK SERVICES?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    28 mar 2019
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6977942
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    06 apr 2016
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01466217
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TREND NETWORK SERVICES ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 26 mar 2004
    Consegnato il 06 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor (or any of them) to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 06 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 30 set 1986
    Consegnato il 03 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from surdidit limited to the chargee pursuant to a facility letter d/d 13/8/86.
    Brevi particolari
    (Please see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 30 set 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0