TREND NETWORK SERVICES
Panoramica
| Nome della società | TREND NETWORK SERVICES |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 01049704 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TREND NETWORK SERVICES?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TREND NETWORK SERVICES?
| Indirizzo della sede legale | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TREND NETWORK SERVICES?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TREND COMMUNICATIONS LIMITED | 12 apr 1972 | 12 apr 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TREND NETWORK SERVICES?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per TREND NETWORK SERVICES?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 29 dic 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Alan Smith il 16 ott 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Notifica di Daisy Telecoms Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Daisy It Services Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 29 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Lewis Mcglennon come amministratore in data 22 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TREND NETWORK SERVICES?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Amministratore | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 181536600001 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Amministratore | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| MARTIN, William Thomas | Segretario | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Segretario | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | 199438590001 | |||||||
| MORTON, Julia Alison | Segretario | 35 Cranesbill Drive OX26 3WQ Bicester Oxfordshire | British | 71324860003 | ||||||
| SEFTON, Michael Edward | Segretario | Oak Cottage Cuckoos Knob Wootton Rivers SN8 4NR Marlborough Wiltshire | British | 51018120001 | ||||||
| SHARP, Lorraine | Segretario | 168 Ember Lane KT10 8EJ Esher Surrey | British | 26356800001 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Segretario | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | British | 80817560001 | ||||||
| SMITH, Stephen James | Segretario | 16 Chiltern Ridge HP14 3SZ High Wycombe Buckinghamshire | British | 10039470001 | ||||||
| STOKES, Reeta | Segretario | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173996330001 | |||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Segretario | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179706050001 | |||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BERTRAM, Peter Michael | Amministratore | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| CLUTTON, Steven | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 158222570001 | |||||
| COURTLEY, David John | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 141213480001 | |||||
| CUNNINGHAM, Hugh Patrick, Sir | Amministratore | Brickyard Farm East Knoyle SP3 6BP Salisbury Wiltshire | British | 3707560001 | ||||||
| CURTIS, Timothy Malise | Amministratore | Street Farmhouse Vernham Street SP11 0EL Andover Hampshire | British | 10381640015 | ||||||
| DAVEY, Brian George | Amministratore | The Hollies Handford Lane Yateley GU17 7BP Camberley Surrey | British | 30963350001 | ||||||
| FISHER, Arthur | Amministratore | The Old Sun Brook Stones OX39 4LY Sydenham Oxford | British | 93317860001 | ||||||
| ILLA, Jordi | Amministratore | Ramon Turro 93 3rd-2nd Barcelona 08005 Spain | Spanish | 76766450001 | ||||||
| LALE, Jean-Pierre | Amministratore | High Street HP23 5AH Tring 24c Herts United Kingdom | French | 135442370001 | ||||||
| LANGLANDS, Alan Dickson | Amministratore | 17 The Glebe Weston Turville HP22 5ST Aylesbury Buckinghamshire | British | 36270170002 | ||||||
| MARKE, Nathan Richard | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MARTIN, William Thomas | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 57302660001 | |||||
| MULLER, Neil Keith | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | 252490400001 | |||||
| NICHOLSON, Peter Frank | Amministratore | 18 Wainwrights HP18 9DT Long Crendon Buckinghamshire | England | British | 242772210001 | |||||
| PATERSON, Ian | Amministratore | 20 Rosslyn Hill Hampstead NW3 5UJ London | British | 46186950001 | ||||||
| RATTRAY, Bruce Davidson | Amministratore | The Little House 34 Parkway GU15 2PE Camberley Surrey | United Kingdom | British | 3071690001 | |||||
| RILEY, Matthew Robinson | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| ROBINSON, Nicholas John | Amministratore | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | 54873290006 | |||||
| ROBINSON, Nicholas | Amministratore | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| RUSSELL, Julian Philip | Amministratore | 2 Shepherds Close OX25 3RF Weston On The Green Shepherds Barn Oxfordshire | United Kingdom | British | 117227890002 | |||||
| SANDER, Bernhard | Amministratore | Avenstr. 10 Pfaffenhofen D- 852 76 Germany | German | 39558960002 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Amministratore | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||
| SMITH, Stephen James | Amministratore | 16 Chiltern Ridge HP14 3SZ High Wycombe Buckinghamshire | British | 10039470001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TREND NETWORK SERVICES?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 28 mar 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Daisy It Services Limited | 06 apr 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TREND NETWORK SERVICES ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Creato il 26 mar 2004 Consegnato il 06 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor (or any of them) to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 30 set 1986 Consegnato il 03 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from surdidit limited to the chargee pursuant to a facility letter d/d 13/8/86. | |
Brevi particolari (Please see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 set 1986 Consegnato il 07 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0