BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01050265 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (46460) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o WELL Merchants Warehouse Castle Street M3 4LZ Manchester England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE CO-OPERATIVE PHARMACY NATIONAL DISTRIBUTION CENTRE LIMITED | 22 nov 2012 | 22 nov 2012 |
| SANTS PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS LIMITED | 27 lug 2012 | 27 lug 2012 |
| THE CO-OPERATIVE PHARMACY NATIONAL DISTRIBUTION CENTRE LIMITED | 20 lug 2009 | 20 lug 2009 |
| SANTS PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS LIMITED | 17 apr 1972 | 17 apr 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 28 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 11 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 28 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Ben Richard Mitchell come amministratore in data 01 lug 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Thorsten Beer come amministratore in data 01 lug 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2024 | 33 pagine | AA | ||
Nomina di Thorsten Beer come amministratore in data 23 ott 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Katherine Rebecca Jacob come amministratore in data 14 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Sebastian Hobbs come amministratore in data 09 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Gregory Vincent Pateras come amministratore in data 09 set 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2023 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2022 | 26 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 010502650007, creata il 14 feb 2023 | 55 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 010502650006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2021 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2020 | 23 pagine | AA | ||
Nomina di Miss Katherine Rebecca Jacob come amministratore in data 29 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Lynette Gillian Krige come amministratore in data 29 gen 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2019 | 17 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Sebastian Hobbs come amministratore in data 27 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di John Branson Nuttall come amministratore in data 27 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Thomas Richard John | Segretario | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | 257912130001 | |||||||
| MITCHELL, Ben Richard | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 274676410001 | |||||
| PATERAS, Gregory Vincent | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 205827940001 | |||||
| BROCKLEHURST, Jonathan David | Segretario | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 49108820004 | ||||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Segretario | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||
| HILTON, Caroline | Segretario | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | 193574620001 | |||||||
| SELLERS, Caroline Jane | Segretario | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 150628070001 | |||||||
| WILLIAMS, George Edwin | Segretario | 6 Mason Drive Biddulph ST8 6SP Stoke On Trent Staffordshire | British | 4804660001 | ||||||
| BARTON, Chris | Amministratore | 70 Belgrave Avenue CW12 1HT Congleton Cheshire | British | 76398210002 | ||||||
| BATTY, Peter David | Amministratore | Church Hill Ingham LN1 2YE Lincoln 2 Lincolnshire United Kingdom | England | British | 140380300001 | |||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Amministratore | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 10084840001 | |||||
| BEER, Thorsten | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | German | 329040080001 | |||||
| BROCKLEHURST, Jonathan David | Amministratore | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 49108820004 | ||||||
| BROOKS, Gerald | Amministratore | Rangers Lodge Hawkstone Park SY4 5LE Marchamley Shrewsbury | British | 4804670001 | ||||||
| BROWN, Roger Graham | Amministratore | 4 South Downs WA16 8ND Knutsford Cheshire | British | 14695620002 | ||||||
| FAIRBROTHER, Lindsey | Amministratore | 8 Basford Bridge Cottages ST13 7EG Cheddleton Staffordshire | British | 73793340001 | ||||||
| FARQUHAR, Gordon Hillocks | Amministratore | 3 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull | United Kingdom | British | 125645380001 | |||||
| GOLDSTRAW, Jennifer Marsha | Amministratore | 8 Ladygates Betley CW3 9AN Crewe Cheshire | British | 23005600001 | ||||||
| GOLDSTRAW, Jennifer Marsha | Amministratore | 8 Ladygates Betley CW3 9AN Crewe Cheshire | British | 23005600001 | ||||||
| HAMILTON, David Allen | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British,Irish | 143338280002 | |||||
| HINE, John Herbert | Amministratore | 43 Fernwood ST16 1NN Stafford | British | 4804690001 | ||||||
| HINE, John Herbert | Amministratore | 43 Fernwood ST16 1NN Stafford | British | 4804690001 | ||||||
| HOBBS, Sebastian | Amministratore | Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 262813420001 | |||||
| JACOB, Katherine Rebecca | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 223624510001 | |||||
| JONES, Philip Robert | Amministratore | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | United Kingdom | English | 43686960001 | |||||
| KEW, Philip Anthony | Amministratore | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||
| KRIGE, Lynette Gillian | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 283338100002 | |||||
| MARKS, Peter Vincent | Amministratore | The Old Barn Low House Farm Otley Road Eldwick BD16 3AZ Bingley West Yorkshire | United Kingdom | British | 87486470001 | |||||
| NUTTALL, John Branson | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | United Kingdom | British | 195408270001 | |||||
| PICKING, David James | Amministratore | 25 Hillside Close ST7 4PQ Mow Cop Staffordshire | England | British | 147803190001 | |||||
| SMITH, Anthony John | Amministratore | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | 137558680001 | |||||
| SMITH, Stephen David | Amministratore | 31 Petworth Road North Finchley N12 9HE London | British | 57196370001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher Howard Gould | Amministratore | 1 Norfolk Road HG2 8DA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 38632440001 | |||||
| WALKER, Ian | Amministratore | 120 Greenbarn Way Blackrod BL6 5TE Bolton Lancashire | British | 66452480001 | ||||||
| WARDLE, Andrew Ralph | Amministratore | Checkley Bank Farm House Checkley ST10 4NF Tean Staffordshire | British | 14481620002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BESTWAY PHARMACY NDC LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestway Panacea Holdings Limited | 06 apr 2016 | Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0