W T AIR CARGO LIMITED
Panoramica
Nome della società | W T AIR CARGO LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01051217 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di W T AIR CARGO LIMITED?
- Trasporto aereo merci (51210) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova W T AIR CARGO LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Australis House Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Middlesex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di W T AIR CARGO LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ABX LOGISTICS (AIR CARGO) LIMITED | 19 feb 2001 | 19 feb 2001 |
W.T.AIR CARGO LIMITED | 24 apr 1972 | 24 apr 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di W T AIR CARGO LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per W T AIR CARGO LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 set 2017
| 8 pagine | SH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bruce James Chaplin il 01 ago 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul William Coutts come amministratore in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bruce James Chaplin il 18 mar 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Bruce James Chaplin come amministratore in data 17 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John David Eyre come amministratore in data 17 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Steven Kurzeja come amministratore in data 01 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Buckerfield come amministratore in data 19 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2016 al 31 mar 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di W T AIR CARGO LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAPLIN, Bruce James | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex | England | South African | Director | 225732400004 | ||||
IRVING, James Francis | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex United Kingdom | Hong Kong | Australian | Commercial Director | 179554360001 | ||||
KURZEJA, Mark Steven | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex | England | British | Director | 213424680001 | ||||
MCGLYNN, Neil Hugh | Segretario | Nods Landing 15/17 The Avenue TW19 5EY Wraysbury Berkshire | British | 31133270001 | ||||||
VENKATESH, Srinivasan | Segretario | 46 West Drayton Park Avenue UB7 7QB West Drayton Middlesex | British | 39630400002 | ||||||
BUCKERFIELD, Stephen | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex United Kingdom | England | British | Director | 98628910002 | ||||
CHANDWANI, Anand Hassan | Amministratore | PO BOX 11340 Dubai Uae | Indian | Company Director | 29576550001 | |||||
COLE, Michael John | Amministratore | Tylers Cottage North End CM6 3PQ Great Dunmow Essex | British | Company Director | 28338950001 | |||||
COUTTS, Paul William | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex United Kingdom | Singapore | British | Director | 177383160001 | ||||
CUSHING, Hugh Joseph | Amministratore | River Gardens North Feltham Trading Estate TW14 0RB Feltham 647 Middlesex United Kingdom | Hong Kong | British | Director | 153665120001 | ||||
EYRE, John David | Amministratore | Unit 2 Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 179316180001 | ||||
FAHY, Christopher John | Amministratore | River Gardens North Feltham Trading Estate TW14 0RB Feltham 647 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 153645820001 | ||||
GALLAGHER, Kevin Patrick | Amministratore | 75 Lodge Close Stoke D Abernon KT11 2SQ Cobham Surrey | United Kingdom | Irish | Chartered Accountant | 2516040001 | ||||
GRIFFIN, Michael Patrick | Amministratore | Glenbeigh House Lyne Court KT16 Chertsey Surrey | British | Company Director | 29576560001 | |||||
HASSAN, Jeffrey Paul | Amministratore | 27 The Street Galleywood CM2 8QN Chelmsford Essex | British | Company Director | 21933770001 | |||||
LEE, Kevin John | Amministratore | 6 Pongola Street Paulshof 2056 FOREIGN South Africa | British | Company Director | 59079130001 | |||||
LITTLE, Paul Alexander | Amministratore | St Kilda Road 3004 Melbourne Level 7, 380 Victoria Australia | Australia | Australian | Director | 150043720001 | ||||
MCGLYNN, Neil Hugh | Amministratore | Nods Landing 15/17 The Avenue TW19 5EY Wraysbury Berkshire | England | British | Company Director | 31133270001 | ||||
MORTER, Gary | Amministratore | River Gardens North Feltham Trading Estate TW14 0RB Feltham 647 Middlesex | England | British | Director | 112495350001 | ||||
MORTER, Gary | Amministratore | 23a Claremont Gardens RM14 1DW Upminster Essex | England | British | Director | 112495350001 | ||||
PEARSON, Robert Kenneth | Amministratore | 11 Waterfall Avenue Craighall Johannesburg Transvaal Rep Of South Africa | South African | Company Director | 37024300002 | |||||
SPROGIS, Peter Rohan | Amministratore | River Gardens North Feltham Trading Estate TW14 0RB Feltham 647 Middlesex | Hong Kong | Australian | Commercial Director | 165887240001 | ||||
VENKATESH, Srinivasan | Amministratore | West Drayton Park Avenue UB7 7QB West Drayton 46 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 39630400002 | ||||
VENKATESH, Srinivasan | Amministratore | 46 West Drayton Park Avenue UB7 7QB West Drayton Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 39630400002 | ||||
WARD, Graham Andrew | Amministratore | Bridge Road Bursledon SO31 8AL Southampton Cutty Sark United Kingdom | England | British | Director | 147000050001 | ||||
WARDMAN, Mark Andrew | Amministratore | River Gardens North Feltham Trading Estate TW14 0RB Feltham 647 Middlesex | England | British | Director | 112066770002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di W T AIR CARGO LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toll Global Forwarding Group (Uk) Ltd | 06 apr 2016 | Heron Way TW14 0AR Feltham Australis House, Unit 2 Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
W T AIR CARGO LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 07 mag 2009 Consegnato il 14 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge of deposit | Creato il 14 mar 2002 Consegnato il 26 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit initially of £5,000 credited to account designation 45434247 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 08 gen 1999 Consegnato il 12 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company to the chargee under the lease dated 8 january 1999 | |
Brevi particolari The sum of £47,735 deposited with the landlord and all interest earned on the deposit from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge supplemental to a mortgage debenture | Creato il 22 apr 1986 Consegnato il 01 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 31/10/78 | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company (see doc M22 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 07 gen 1986 Consegnato il 11 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari A) fixed charge over all stock in trade b) fixed charge over all bookdebts & other debts c) floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital d) by way of legal mortgage the premises described in the schedule of the mortgage debenture with all buildings, fixtures, plant & machinery (see doc M21 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 31 ott 1978 Consegnato il 09 nov 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital all stocks shares and other securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0