HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED

HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01051510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASSETFINANCE DECEMBER (G) LIMITED27 set 199927 set 1999
    FF LIMITED27 mag 199427 mag 1994
    FIAT FINANCE LIMITED25 apr 197225 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 12 ott 2016

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Cessazione della carica di Robin Louis Henning Bencard come amministratore in data 01 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Nomina di Mr Simon Einar Long come amministratore in data 15 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Cavanna come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Connelly Anderson come amministratore in data 16 dic 2015

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Varie

    Section 519.
    1 pagineMISC

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    19 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Ms Romana Lewis come segretario in data 06 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 06 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Nomina di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 05 gen 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tony Bhambhra come segretario in data 05 gen 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Naresh Manjanath come amministratore in data 11 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2014

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Nomina di Tony Bhambhra come segretario

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Segretario
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    199208910001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    186837800001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180091350001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Segretario
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    British109247130002
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Segretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194218040001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911830001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    165563750001
    ANDREONE, Gianfranco
    Corso Siracusa N 79
    FOREIGN Italy
    Amministratore
    Corso Siracusa N 79
    FOREIGN Italy
    Italian32099940001
    ARMSTRONG, John Osborne William
    The Nook 372 Alcester Road
    Burcot
    B60 1PP Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    The Nook 372 Alcester Road
    Burcot
    B60 1PP Bromsgrove
    Worcestershire
    British31196620002
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BODEGA, Charles Anthony
    30 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    30 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British33601160001
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    BROOKES, Malcolm James
    15 St Lukes Close
    Four Pools
    WR11 6ET Evesham
    Hereford And Worcester
    Amministratore
    15 St Lukes Close
    Four Pools
    WR11 6ET Evesham
    Hereford And Worcester
    British61727900002
    BROWN, Robin James
    33 Wheatsheaf Road
    Edgbaston
    B16 0RZ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    33 Wheatsheaf Road
    Edgbaston
    B16 0RZ Birmingham
    West Midlands
    British9800820001
    CARELLO, Massimo, Dr
    20 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Amministratore
    20 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Italian35566160001
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Amministratore
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    CENTONZE, Giuseppe
    5 Harrington Close
    SL4 4AD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    5 Harrington Close
    SL4 4AD Windsor
    Berkshire
    Italian27832010001
    DI CAPUA, Vittorio Augusto
    Via Mazzini 51/53
    FOREIGN Torino 10124
    Italy
    Amministratore
    Via Mazzini 51/53
    FOREIGN Torino 10124
    Italy
    Italian27832040001
    DORIA, Bruno
    Via Mazzini 51/53
    Torino
    Italy
    Amministratore
    Via Mazzini 51/53
    Torino
    Italy
    Italian55825630003
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001

    HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from company or hsbc bank PLC to the secured parties or to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America N.A.,in Its Capacity as the Security Trustee
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Specific legal mortgage no.6 In respect of the containers (as defined therein)
    Creato il 31 gen 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Brevi particolari
    All the right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage no.5 In respect of the containers (as defined therein)
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 04 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage no.4 In respect of the containers (as defined therein)
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 02 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined therein)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 02 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage no.3 In respect of the containers (as defined)
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevnt aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (please refer to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage no.2 In respect of the containers (as defined)
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 07 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Brevi particolari
    All right,title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage no. 1 between the company and p&o nedlloyd limited in respect of the containers
    Creato il 31 mag 2000
    Consegnato il 16 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease (as defined) and the dpp (as defined)
    Brevi particolari
    The company as beneficial owner assigns and agrees to assigns all present and future right and title to and interest in the containers such as the company received pursuant to the relevant acquisition agreement and to the proceeds of sale thereof and charges the containers and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of mortgage in respect of the containers
    Creato il 18 apr 2000
    Consegnato il 08 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease and the dpp: (a) to pay to the mortgagee any and all amounts in respect of rebates of rent and termination sums,total loss proceeds or net sales proceeds payable to the mortgagee in accordance with the provisions of clauses 20.6.4 and 24.4.4 of the lease; (b) to discharge any lessor's encumbrances in accordance with clause 6.3 of the lease; and (c) perform its obligations under clause 19.4 of the lease and clauses 14.4,14.5,14.6 and 14.8 of the dpp and paragraphs 2.5 and 2.8 of schedule 3 of the dpp
    Brevi particolari
    All right,title and interest (if any) present and future of the company in and to each of the containers as the company shall have received pursuant to the acquisition agreement in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Lessor proceeds account charge
    Creato il 18 apr 2000
    Consegnato il 04 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The express and specific obligations of the company to the chargee under (a) clause 20.6 (application of net total loss proceeds, requisition compensation and other compensation) and (b) clause 24.4 (application of the net sale proceeds) of the lease agreement dated 8TH april 2000 as amended and restated pursuant to a deed of amendment and restatement dated 18TH april 2000, being the obligations to rebate to the chargee by way of rebate of rent or termination amount
    Brevi particolari
    The company's rights title and interest present and future in and to the charged moneys being all moneys standing to the credit of the interest bearing dollar account of the company designated "lessor proceeds account" and with account no.242891. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0