AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED

AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01051698
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AUTOSPEED TYRES (HOLDINGS) LIMITED26 apr 197226 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ott 2012

    Stato del capitale al 23 ott 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Stato del capitale al 01 ago 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce capital redemption erserve 04/07/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Kazushi Ogura come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Kenji Murai come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Healy come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael Healy come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Fraser come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Ian Vincent Ellis come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 02 ago 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Ellis Fraser il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Ian Vincent
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    British162126790001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    CLAPP, John Leslie
    Lansdowne Cotswold Lane
    Old Sodbury
    BS37 6NE Bristol
    Segretario
    Lansdowne Cotswold Lane
    Old Sodbury
    BS37 6NE Bristol
    British50237790001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Segretario
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Segretario
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Amministratore
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    CLAPP, Adrian Paul
    18 Perrinpit Road
    Frampton Cotterell
    BS17 2AT Bristol
    Avon
    Amministratore
    18 Perrinpit Road
    Frampton Cotterell
    BS17 2AT Bristol
    Avon
    British9794620001
    CLAPP, John Leslie
    Lansdowne Cotswold Lane
    Old Sodbury
    BS37 6NE Bristol
    Amministratore
    Lansdowne Cotswold Lane
    Old Sodbury
    BS37 6NE Bristol
    British50237790001
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Amministratore
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritish94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Amministratore
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    British712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Amministratore
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    British3204110005
    LANDAU, Ervin
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    Amministratore
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    United KingdomBritish91134410001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Amministratore
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001

    AVON AND WILTSHIRE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 20 ott 1989
    Consegnato il 25 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold premises K.A. the boundary works, shrivenham rd, swindon, wilts. Floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 12 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises k/as unit 5 the vines industrial centre nailsea avon. Floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1989
    Consegnato il 04 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises k/a 87 bath road, longwell green, bristol, avon t/n av 20490 floating charge over all movable plant machinery implements utentsils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 mar 1985
    Consegnato il 20 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating & charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1983
    Consegnato il 03 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    24/26 station road, yate, nr. Bristol, avon. Floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ott 1982
    Consegnato il 23 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    80 north road yate avon title no:- gr 29613 floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ott 1982
    Consegnato il 23 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Durham down garage north view westbury on trym bristol title no:- av 58223. floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 set 1982
    Consegnato il 27 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bridge garage, cardiff road, treforest, pontypridd, S. wales. T.n- wa 157208.
    Persone aventi diritto
    • The National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 set 1982
    Consegnato il 27 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    24/26/28 station hill, chippenham, wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • The National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 set 1982
    Consegnato il 23 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 16/18 bath rd, keynsham in the county of avon floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0