R.G. FRANCIS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | R.G. FRANCIS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01052014 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di R.G. FRANCIS LIMITED?
- Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni
Dove si trova R.G. FRANCIS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Crown House Birch Street WV1 4JX Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di R.G. FRANCIS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ESSEX WATER PLUMBING LIMITED | 18 apr 1991 | 18 apr 1991 |
| HARLING HEATING (CHELMSFORD) LIMITED | 28 apr 1972 | 28 apr 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di R.G. FRANCIS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per R.G. FRANCIS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alison Margaret Shepley come segretario in data 21 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 01 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Energy Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 25 giu 2018 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 20 nov 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 31 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Hayward il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di R.G. FRANCIS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPP, Richard Francis | Amministratore | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | England | British | 173852420001 | |||||
| JAMES, Kerry Jane | Segretario | 10 Tintagel Way CM9 6YR Maldon Essex | British | 48603070002 | ||||||
| JONES, Maureen Anne | Segretario | Tamarind Elm Green Lane Danbury CM3 4DW Chelmsford Essex | British | 26849680001 | ||||||
| JUDD, Christopher | Segretario | Regent Farm Road Regent Centre Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear United Kingdom | British | 69049410002 | ||||||
| SHEPLEY, Alison Margaret | Segretario | 7-12 Tavistock Street WC1H 9LT London Lynton House, 2nd Floor United Kingdom | 160706080001 | |||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BAILEY, John Roger | Amministratore | Regent Farm Road Regent Centre Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 36401580001 | |||||
| GUISE, Ashley Charles | Amministratore | Eaga House Archbold Terrace Jesmond NE2 1DB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 127062710002 | |||||
| HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HODGES, David | Amministratore | Laburnum House West Thirston NE65 9EF Morpeth Northumberland | British | 103341630001 | ||||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| JAMES, Kerry Jane | Amministratore | 10 Tintagel Way CM9 6YR Maldon Essex | British | 48603070002 | ||||||
| JAMES, Timothy John | Amministratore | 10 Tintagel Way CM9 6YR Maldon Essex | British | 54317140002 | ||||||
| JOHNSON, Andrea Louise | Amministratore | 30 Handley Cross Medomsley DH8 6TZ Consett County Durham | British | 122760450001 | ||||||
| JONES, Derek Charles | Amministratore | Tamarind Elm Green Lane CM3 4DW Danbury Essex | British | 50413820001 | ||||||
| JONES, Maureen Anne | Amministratore | Tamarind Elm Green Lane Danbury CM3 4DW Chelmsford Essex | British | 26849680001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| MC MAHON, Michael | Amministratore | Eaga House Archbold Terrace Jesmond NE2 1DB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 135269140001 | |||||
| MCDONOUGH, John | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| RING, Alan Frederick | Amministratore | Regent Farm Road Regent Centre Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 10873270003 | |||||
| RODGERS, Richard | Amministratore | Regent Farm Road Regent Centre Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear United Kingdom | Northern Ireland | British | 155728470001 | |||||
| SMEETON, Stephen Thomas Alfred | Amministratore | 67 Widford Road CM2 8SY Chelmsford Essex | British | 26849660001 | ||||||
| SPANN, Neil | Amministratore | Regent Farm Road Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 154870250001 | |||||
| VARLEY, Paul Richard | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 137984880002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di R.G. FRANCIS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Energy Services Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
R.G. FRANCIS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Memorandum of security over cash deposits | Creato il 03 feb 2009 Consegnato il 04 feb 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari With full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of all the indebtednesses, liabilities and obligations referred to by way of first fixed charge the deposit meaning the sum of $127,948.00 agreed to be deposited and each and every debt represented by the deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 giu 2005 Consegnato il 16 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 gen 1999 Consegnato il 28 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 mag 1978 Consegnato il 07 giu 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The builders yard, the street, galleywood, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 05 set 1973 Consegnato il 25 set 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 287 baddow road, chelmsford essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0