R.G. FRANCIS LIMITED

R.G. FRANCIS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR.G. FRANCIS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01052014
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R.G. FRANCIS LIMITED?

    • Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni

    Dove si trova R.G. FRANCIS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Crown House
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R.G. FRANCIS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ESSEX WATER PLUMBING LIMITED18 apr 199118 apr 1991
    HARLING HEATING (CHELMSFORD) LIMITED28 apr 197228 apr 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di R.G. FRANCIS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per R.G. FRANCIS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Alison Margaret Shepley come segretario in data 21 dic 2018

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 01 ott 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Carillion Energy Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 25 giu 2018

    1 pagineCH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 20 nov 2017

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017

    2 pagineCH01

    Nomina di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 31 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2016

    Stato del capitale al 15 apr 2016

    • Capitale: GBP 166,400
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2015

    Stato del capitale al 15 apr 2015

    • Capitale: GBP 166,400
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Hayward il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di R.G. FRANCIS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAPP, Richard Francis
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    EnglandBritish173852420001
    JAMES, Kerry Jane
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    Segretario
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    British48603070002
    JONES, Maureen Anne
    Tamarind Elm Green Lane
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Tamarind Elm Green Lane
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    British26849680001
    JUDD, Christopher
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Segretario
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    British69049410002
    SHEPLEY, Alison Margaret
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Segretario
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    160706080001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    BAILEY, John Roger
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish36401580001
    GUISE, Ashley Charles
    Eaga House
    Archbold Terrace Jesmond
    NE2 1DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Eaga House
    Archbold Terrace Jesmond
    NE2 1DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish127062710002
    HAYWARD, Alan
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154549030001
    HODGES, David
    Laburnum House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Laburnum House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    British103341630001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    JAMES, Kerry Jane
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    Amministratore
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    British48603070002
    JAMES, Timothy John
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    Amministratore
    10 Tintagel Way
    CM9 6YR Maldon
    Essex
    British54317140002
    JOHNSON, Andrea Louise
    30 Handley Cross
    Medomsley
    DH8 6TZ Consett
    County Durham
    Amministratore
    30 Handley Cross
    Medomsley
    DH8 6TZ Consett
    County Durham
    British122760450001
    JONES, Derek Charles
    Tamarind
    Elm Green Lane
    CM3 4DW Danbury
    Essex
    Amministratore
    Tamarind
    Elm Green Lane
    CM3 4DW Danbury
    Essex
    British50413820001
    JONES, Maureen Anne
    Tamarind Elm Green Lane
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Tamarind Elm Green Lane
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    British26849680001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    MC MAHON, Michael
    Eaga House
    Archbold Terrace Jesmond
    NE2 1DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Eaga House
    Archbold Terrace Jesmond
    NE2 1DB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish135269140001
    MCDONOUGH, John
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    UkBritish74536340007
    RING, Alan Frederick
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish10873270003
    RODGERS, Richard
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Farm Road
    Regent Centre Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish155728470001
    SMEETON, Stephen Thomas Alfred
    67 Widford Road
    CM2 8SY Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    67 Widford Road
    CM2 8SY Chelmsford
    Essex
    British26849660001
    SPANN, Neil
    Regent Farm Road
    Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Farm Road
    Gosforth
    NE3 3AF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154870250001
    VARLEY, Paul Richard
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    United Kingdom
    Amministratore
    City West Business Park
    Scotswood Road
    NE4 7DF Newcastle Upon Tyne
    Partnership House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137984880002

    Chi sono le persone con controllo significativo di R.G. FRANCIS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03858865
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    R.G. FRANCIS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Memorandum of security over cash deposits
    Creato il 03 feb 2009
    Consegnato il 04 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of all the indebtednesses, liabilities and obligations referred to by way of first fixed charge the deposit meaning the sum of $127,948.00 agreed to be deposited and each and every debt represented by the deposit.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 04 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 giu 2005
    Consegnato il 16 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 16 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 gen 1999
    Consegnato il 28 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 1978
    Consegnato il 07 giu 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The builders yard, the street, galleywood, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 set 1973
    Consegnato il 25 set 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    287 baddow road, chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1973Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0