FIBRACAN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FIBRACAN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01053677 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FIBRACAN LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova FIBRACAN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FIBRACAN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 03 apr 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per FIBRACAN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Dieter Bergner come amministratore in data 01 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Veriplast International Dragonville Estate Durham Co Durham DH1 2RL in data 30 nov 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2012 al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Dieter Bergner come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philipe Langelier come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Philipe Andre Rene Langelier come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thierry Tomasov come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Thierry Tomasov il 08 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Hart il 08 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Christopher Hart il 08 mar 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FIBRACAN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HART, Christopher | Segretario | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | British | 135520940001 | ||||||
| HART, Christopher | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | Netherlands | British | 135520940002 | |||||
| DAWSON, Stephen Robin | Segretario | Malita Rickmanhill Road CR5 3LA Chipstead Surrey | British | 102972940001 | ||||||
| GRANVILLE, Stephen Geoffrey | Segretario | 27 Lunedale Avenue Tollesby TS5 7LA Middlesbrough | British | 81158220001 | ||||||
| MCKAY, William Trevor | Segretario | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | 588890001 | ||||||
| BAUCUTT, Thomas Andrew William | Amministratore | Condor 18 Hazel Grove Tarleton PR4 6DQ Preston Lancashire | British | 8622840001 | ||||||
| BERGNER, Dieter | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | Germany | Dutch | 161017630001 | |||||
| BERNARD, Gilles | Amministratore | 20 Allee De L'Enclos 38240 Meylan France | French | 133876950001 | ||||||
| COUSERGUE, Cyrille | Amministratore | 8 Rue De La Plaine, 95600 Aubonne France | French | 131156700001 | ||||||
| CUNLIFFE, Andrew Harvey | Amministratore | Easter Cottage 27 Cedar Street LE15 8QS Braunston Leicestershire | England | British | 103722290001 | |||||
| DAVEY, Michael John | Amministratore | 225 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | United Kingdom | British | 976330001 | |||||
| DAWSON, Stephen Robin | Amministratore | Malita Rickmanhill Road CR5 3LA Chipstead Surrey | England | British | 102972940001 | |||||
| EDWARDS, David Michael | Amministratore | 3 Highgate DH1 4GA Durham | British | 85213540001 | ||||||
| GOMEZ, Raul Pacios | Amministratore | 8 Rue Claude Debussy Essert 90850 France | Spanish | 120034790001 | ||||||
| GRANVILLE, Stephen Geoffrey | Amministratore | 27 Lunedale Avenue Tollesby TS5 7LA Middlesbrough | British | 81158220001 | ||||||
| HOBBS, David Dudley | Amministratore | 15 Greenside Edgcumbe Park RG45 6EX Crowthorne Berkshire | British | 37745610001 | ||||||
| HOUGHTON, Nicholas Anthony | Amministratore | 19 Highfield Drive Standish WN6 0EJ Wigan Lancashire | British | 54012850001 | ||||||
| KEY, John Michael, Dr. | Amministratore | 10 Chapmans Court Catterick Village DL10 7UE Richmond North Yorkshire | England | British | 105107140001 | |||||
| LANGELIER, Philipe Andre Rene | Amministratore | Le Garay De La Croix Monistrol Sur Loire 43 120 France | France | French | 158292670001 | |||||
| MASSON, Eric Marcel Marie Jacques | Amministratore | 18 Allee Du Gaillet Meyland 38240 France | French | 120035220001 | ||||||
| MITCHELL, Philip Garnet | Amministratore | Cherry Tree Close Pannal Ash Road HG2 9AL Harrogate North Yorkshire | British | 8512990001 | ||||||
| NUNWICK, David Anthony | Amministratore | 8 Ashmeadow Lane Brinscall PR6 8JU Chorley Lancashire | British | 8622850001 | ||||||
| O'LEARY, Mark Joseph Christopher | Amministratore | 14 Meadow View SL7 3PA Marlow Bottom Buckinghamshire | Irish | 43800040002 | ||||||
| PAGE, Geoffrey Stuart | Amministratore | 10 Chiswick Gardens Appleton WA4 5HQ Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 8622860001 | |||||
| ROLT, Arthur Ernest | Amministratore | 11 Kenilworth Road Ainsdale PR8 3PE Southport Merseyside | British | 8622870001 | ||||||
| ROSTRON, Eddie | Amministratore | 12 Dorset Road Rishton BB1 4BW Blackburn Lancashire | British | 28849190001 | ||||||
| SCHMITT, Remy | Amministratore | 10 Boulevard Emile Augier, 75016 Paris France | French | 131156740001 | ||||||
| SMADJA, Olivier Georges | Amministratore | 3 Rue De Planit FOREIGN Sainte Foy Les Lyon 69110 France | French | 100503720001 | ||||||
| TOMASOV, Thierry | Amministratore | 9 Avenue Bedoyere Garches 92380 France | France | French | 101382570003 | |||||
| TUCKER, Michael Andrew | Amministratore | 3 Harrod Drive Birkdale PR8 2HA Southport Merseyside | British | 12893290003 | ||||||
| WALFORD, Anthony William Cecil | Amministratore | Toque House Salters Meadow Beacon Hill HP10 8NH Penn Buckinghamshire | British | 2198510001 | ||||||
| YOUNG, John Alexander | Amministratore | 32 Eastlea Avenue Garston WD2 4RH Watford Hertfordshire | British | 44701870001 |
FIBRACAN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Omrubus letter of set-off | Creato il 31 mar 1987 Consegnato il 14 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Inter-company letter of set off | Creato il 01 ago 1983 Consegnato il 18 ago 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral mortgage | Creato il 07 mag 1980 Consegnato il 12 mag 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies advanced or to be advanced under the terms of an agreement dated 7.5.80 and all other monies due or to become due from antobar industries LTD to the chargee | |
Brevi particolari See schedule attached to doc M26. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0