ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01054993 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Paul's House 4th Floor 10 Warwick Lane EC4M 7BP London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CITY & FOREIGN LIMITED | 11 dic 1987 | 11 dic 1987 |
| ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY LIMITED | 18 mag 1972 | 18 mag 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael David Comras come amministratore in data 07 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Povey come amministratore in data 07 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles William Ansley come amministratore in data 07 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Charlotte Kate Partridge come segretario in data 07 set 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles William Ansley come segretario in data 07 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7RB a St Paul's House 4th Floor 10 Warwick Lane London EC4M 7BP in data 01 set 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles William Ansley come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karin Mclean come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTRIDGE, Charlotte Kate | Segretario | 10 Warwick Lane EC4M 7BP London St Paul's House 4th Floor England | 237648760001 | |||||||
| COMRAS, Michael David | Amministratore | 10 Warwick Lane EC4M 7BP London St Paul's House 4th Floor England | England | British | 71630180001 | |||||
| STAGG, Nicholas Simon | Amministratore | 10 Warwick Lane EC4M 7BP London St Paul's House 4th Floor England | United Kingdom | British | 153427650001 | |||||
| ANSLEY, Charles William | Segretario | Sinclair Gardens W14 0AU London 7 United Kingdom | 163569100001 | |||||||
| CONNOLE, Michael Damien | Segretario | 117 Thornbury Road TW7 4ND Isleworth Middlesex | Irish | 47934750001 | ||||||
| DUMOND, Paul George | Segretario | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | 266200001 | ||||||
| HITCHCOCK, Frederick Steven | Segretario | 243 Murray Court Jupiter Florida 33458 Usa | American | 54069430002 | ||||||
| LASHER, Cathy | Segretario | 61 Stile Hall Gardens W4 3BT London | British | 30066230001 | ||||||
| MCLEAN, Karin | Segretario | 27 Gloucester Road TW12 2UQ Hampton Middlesex | Belgian | 72615450003 | ||||||
| SWITALSKI, Gillian Eileen | Segretario | Kings Copse Waverley Drive GU25 4PZ Virginia Water Surrey | British | 152311140001 | ||||||
| ANSLEY, Charles William | Amministratore | 7 Sinclair Gardens W14 0AU London | United Kingdom | British | 18592040001 | |||||
| BROWN, Gail Patricia | Amministratore | 2 Ashley Park SL6 8EZ Maidenhead Berkshire | Australian | 50723870001 | ||||||
| CONNOLE, Michael Damien | Amministratore | 117 Thornbury Road TW7 4ND Isleworth Middlesex | England | Irish | 47934750001 | |||||
| CURRIE, Mark Andrew | Amministratore | Heathcote Fairoak Lane KT22 0TP Oxshott Surrey | England | British | 147327230001 | |||||
| GEORGE, Paul | Amministratore | 26 Stradella Road SE24 9HA London | England | British | 67765840001 | |||||
| GILL, David Alan | Amministratore | 5 Chanctonbury Drive SL5 9PT Sunningdale Berkshire | England | British | 37437870002 | |||||
| HAMILTON, Neil | Amministratore | One Inlet Cay Drive FOREIGN Ocean Ridge Florida 33435 Usa | Canadian | 5150850001 | ||||||
| HITCHCOCK, Frederick Steven | Amministratore | 243 Murray Court Jupiter Florida 33458 Usa | American | 54069430002 | ||||||
| HUGHES, Malcolm Keith | Amministratore | Old Orchard 6 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | British | 40853070003 | ||||||
| PARRY, Kevin Allen Huw | Amministratore | 85 Cambridge Street SW1V 4PY London | United Kingdom | British | 93039000001 | |||||
| POVEY, Christopher John | Amministratore | Shooters Hill Road Blackheath SE3 8UQ London 145 United Kingdom | England | British | 127223610001 | |||||
| PURSE, Stephen John | Amministratore | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | England | British | 58759290001 | |||||
| RHODES, Michael | Amministratore | 11 Eastwinds Cr FOREIGN Tequesta Florida 33469 Usa | United States | American | 30059330001 | |||||
| SMITH, Craig Harold | Amministratore | Orchard View Shenley Hill WD7 7AT Radlett Hertfordshire | England | British | 67303230002 | |||||
| SMYTH, Andrew Lawrence Robin | Amministratore | 14 Glenlyon Road Eltham SE9 1AJ London | Uk | British | 116865940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Consulting Group Plc | 06 apr 2016 | Fleet Place EC4M 7RB London 10 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ALEXANDER PROUDFOOT COMPANY OF EUROPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 13 mar 2001 Consegnato il 24 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 16 mag 1994 Consegnato il 25 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee or any of the banks on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge over the debts floating charge over the whole of its undertaking, property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 18 feb 1992 Consegnato il 03 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 12/05/89 and any other finance document | |
Brevi particolari First fixed charge the deposit and the debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0