GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED

GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGBC (UNITED KINGDOM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01056410
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IBICO LIMITED31 mag 197231 mag 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem and capital contribution reserve 09/08/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 11 ago 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Katherine Alexandra Spence il 10 mag 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Katherine Alexandra Spence il 10 mag 2021

    1 pagineCH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Accounts approved, company not required to hold a general meeting 29/01/2021
    RES13

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher Neil Hopkinson come amministratore in data 05 giu 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Katherine Alexandra Spence come amministratore in data 05 giu 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Walter Joe Thomas come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Katherine Alexandra Spence come segretario in data 05 giu 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robert Michael Grimes come segretario in data 01 giu 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Nomina di Mr Robert Michael Grimes come segretario in data 30 apr 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher Neil Hopkinson come amministratore in data 30 apr 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIOR, Katherine Alexandra
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    270502710002
    HOPKINSON, Christopher Neil, Mr.
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish270498480001
    PRIOR, Katherine Alexandra
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish248359400002
    BARKER, Ruth
    77 The Crofts
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    77 The Crofts
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British99632990001
    DOVER, Paul William
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    British48335550001
    EVANS, Paul William Hywel
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    British80520290001
    GEDDIE, Richard Mark
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    British80783870001
    GRIMES, Robert Michael
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    245928620001
    MORRIS, Ruth Margaret
    61 Wordsworth Road
    TW12 1EW Hampton
    Middlesex
    Segretario
    61 Wordsworth Road
    TW12 1EW Hampton
    Middlesex
    British39201870001
    VALE, Ronald Edward
    5 Ashwood Drive
    BH18 8LN Broadstone
    Dorset
    Segretario
    5 Ashwood Drive
    BH18 8LN Broadstone
    Dorset
    British5033030001
    ATTRIDGE, David Roy
    40 Meadowridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    40 Meadowridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    British56376820002
    BEERKENS, Michel Antoon Victor
    Geldropseweg 19
    Heeze 5591ea
    Netherlands
    Amministratore
    Geldropseweg 19
    Heeze 5591ea
    Netherlands
    Dutch80928430002
    DAVIES, Emma Susan
    Lawn Hill Cottage
    OX17 1ET Claydon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lawn Hill Cottage
    OX17 1ET Claydon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish126575640001
    DOVER, Paul William
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish48335550001
    EVANS, Paul William Hywel
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    British80520290001
    FIRTH, Stephen
    2 Lansdowne Road
    Frimley
    GU16 5UW Camberley
    Surrey
    Amministratore
    2 Lansdowne Road
    Frimley
    GU16 5UW Camberley
    Surrey
    British56829340001
    GEDDIE, Richard Mark
    Bricket Wood
    AL2 3ST St Albans
    15 Pine Grove
    Herts
    England
    Amministratore
    Bricket Wood
    AL2 3ST St Albans
    15 Pine Grove
    Herts
    England
    EnglandBritish80783870001
    GREEN, Howard Benjamin
    1325 North Sutton Place
    60610 Chicago
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1325 North Sutton Place
    60610 Chicago
    Illinois
    Usa
    American57046060002
    GUEST, Richard Hamilton
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    Amministratore
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    EnglandBritish122869580001
    HOPKINSON, Christopher Neil, Mr.
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish270498480001
    MOSELEY, Elizabeth Violet
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Oxford House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Oxford House
    Buckinghamshire
    EnglandBritish193913710001
    MUGRIDGE, Ellis John
    58 Wentworth Crescent
    RG22 4WX Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    58 Wentworth Crescent
    RG22 4WX Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish115153160001
    MUNK, Peter
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    United KingdomDanish112581070001
    PAGE, Andrew Stephen
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish86557080001
    REDDY, Govi
    14 Long Meadow Drive
    60010 Barrington Hills
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    14 Long Meadow Drive
    60010 Barrington Hills
    Illinois
    Usa
    American57046400001
    RUBIN, Steven
    4 Norbert Drive
    Hawthorn Woods
    Illinois 60047
    Usa
    Amministratore
    4 Norbert Drive
    Hawthorn Woods
    Illinois 60047
    Usa
    American56376640004
    STENEBRING, Thomas
    Av. Des Alouettes 50
    Rhode-St-Genese
    B-1640
    Belgium
    Amministratore
    Av. Des Alouettes 50
    Rhode-St-Genese
    B-1640
    Belgium
    Swedish71744640001
    THEIL FARTH, Rainer Erwin
    9 Brampton Chase
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    9 Brampton Chase
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    British39201670001
    THOMAS, Walter Joe, Dr
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish217919870001
    WOLFENSBERGER, Ulrich Andreas, Dr
    Seestrasse 79
    FOREIGN Rushlikon Zh 8803
    Switzerland
    Amministratore
    Seestrasse 79
    FOREIGN Rushlikon Zh 8803
    Switzerland
    Swiss11149790001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    01 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 set 2009
    Consegnato il 08 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the other foreign credit parties to the lender creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 08 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 dic 2003
    Consegnato il 03 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (Security Holder)
    Transazioni
    • 03 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 mar 2001
    Consegnato il 28 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 15 apr 1996
    Consegnato il 18 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company to the credit of the account(s) with the bank re: ibico LTD business premium account no. 80389226 and/or any additional and/or substitute account(s) opened with the bank (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) respresenting the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of transfer
    Creato il 15 feb 1996
    Consegnato il 06 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    Brevi particolari
    All freehold and leasehold property of the company situate in england and wales. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Chicago
    Transazioni
    • 06 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 12 apr 1995
    Consegnato il 24 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all deposits as shown in the schedule and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 apr 1994
    Consegnato il 22 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nbd Bank N.A.
    Transazioni
    • 22 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0