M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED

M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàM.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01060409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower 42 Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Cessazione della carica di Nicola Challen come segretario in data 15 nov 2012

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 05 set 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2012

    Stato del capitale al 02 feb 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 20 ott 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 20/10/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Robert Stevens come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barry Ward come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Evans come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robin James Stewart come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Richard Mainwaring il 29 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Remove s/cap clause 18/06/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Barry Charles Bernard Ward il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Keith Evans il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Richard Mainwaring il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Brian Stevens il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAINWARING, Paul Richard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish116302540002
    STEWART, Robin James
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Segretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Segretario
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Segretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Segretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Segretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    RAVER, Harold Mark
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    Segretario
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    British1493340004
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Segretario
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    BALTES, Edward Charles
    23 Independence Drive
    Manhasset Hills
    FOREIGN Long Island
    New York 11040
    Usa
    Amministratore
    23 Independence Drive
    Manhasset Hills
    FOREIGN Long Island
    New York 11040
    Usa
    Usa21696050001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Amministratore
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritish35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Amministratore
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    EVANS, Andrew Keith
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish124021620001
    FEGEL, Samy
    Lattenstrasse 67
    8142 Uitikon Zurich
    FOREIGN
    Switzerland
    Amministratore
    Lattenstrasse 67
    8142 Uitikon Zurich
    FOREIGN
    Switzerland
    British3143270001
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Amministratore
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Australian113674080001
    HOOPER, David Charles
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    British85448170001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Amministratore
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Amministratore
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Australian42704380002
    KELSON, Christopher John Kerry
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    Amministratore
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    British2039010003
    KNOWLES, Michael Anthony
    33 Colbert Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3BH Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    33 Colbert Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3BH Southend On Sea
    Essex
    British17009660001
    PLASCO, Joel Darren
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    Amministratore
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    British78522900003
    POTTER, Michael John William
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish21712170002
    RILEY, Jacqueline Anne Louise
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    Amministratore
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    EnglandBritish38508990001
    STEVENS, Robert Brian
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish129608370001
    TAYLOR, Kim Michael
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    Amministratore
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    British34697370003
    WARD, Barry Charles Bernard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish126732970001

    M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mag 1999
    Consegnato il 16 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee each and every liability arising under the finance documents which the company may have had at the time the debenture was entered into or thereafter have to the security trustee or any of the beneficiaries and pay to the security trustee every sum now or thereafter owing due or incurred by the company to the security trustee or any of the beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 23 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Tokyo International Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 23 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 28 feb 1989
    Consegnato il 13 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the lenders as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of the guarantee & dated 28/2/89 or this deed.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific National Bank
    Transazioni
    • 13 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 27 feb 1989
    Consegnato il 08 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the banks as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of the guarantee of even date and/or this deed and/or if the charger become & an alternative borrower under the loan agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific National Bank
    Transazioni
    • 08 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    M.W. MARSHALL (OVERSEAS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 set 2012Inizio della liquidazione
    24 mar 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0