XYZ 123 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàXYZ 123 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01062299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di XYZ 123 LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova XYZ 123 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Psl House
    Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Beds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di XYZ 123 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POWER SEMI-CONDUCTORS LIMITED21 lug 197221 lug 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di XYZ 123 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per XYZ 123 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2016

    Stato del capitale al 15 gen 2016

    • Capitale: GBP 70
    SH01

    Cessazione della carica di Richard Terence Ellis come amministratore in data 06 nov 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Hurst Downton come segretario in data 30 giu 2015

    1 pagineTM02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed power semi-conductors LIMITED\certificate issued on 28/05/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 apr 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 dic 2014

    Stato del capitale al 19 dic 2014

    • Capitale: GBP 70
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2013

    Stato del capitale al 23 dic 2013

    • Capitale: GBP 70
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Christopher Morgan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert George Golden il 12 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert George Golden il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher David Morgan il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di XYZ 123 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROXFORD, Daniel
    40 Down Road
    LU5 4DD Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    40 Down Road
    LU5 4DD Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish106036840001
    GOLDEN, Robert George
    Weighbridge Court
    Irlam
    M44 6TJ Manchester
    7
    Lancashire
    Amministratore
    Weighbridge Court
    Irlam
    M44 6TJ Manchester
    7
    Lancashire
    United KingdomBritish105459830001
    DOWNTON, Christopher Hurst
    The Barns
    Little Lane
    DN10 4RY Gringley On The Hill
    South Yorkshire
    Segretario
    The Barns
    Little Lane
    DN10 4RY Gringley On The Hill
    South Yorkshire
    British154777780001
    LEE, Patricia
    3 Farraline Road
    WD18 0DQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Farraline Road
    WD18 0DQ Watford
    Hertfordshire
    British73649080001
    SYDNEY, Esther
    8 The Dart
    Grovehill
    HP2 6EW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    8 The Dart
    Grovehill
    HP2 6EW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37242150002
    SYDNEY, Susan Ann
    Hollytree Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hollytree Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    British1929090001
    ELLIS, Richard Terence
    Ingleford 3 Orchard Mill
    Riversdale
    SL8 5XP Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ingleford 3 Orchard Mill
    Riversdale
    SL8 5XP Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish822390003
    MORGAN, Christopher David
    4 Wentworth Road
    SG13 8JP Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Wentworth Road
    SG13 8JP Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106036970001
    SYDNEY, Peter
    Highways Farm Rushmere Lane
    Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Highways Farm Rushmere Lane
    Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    British1929100004

    Chi sono le persone con controllo significativo di XYZ 123 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Psl Group (Uk) Limited
    Eastern Avenue Industrial Estate, Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Psl Group
    England
    01 ago 2016
    Eastern Avenue Industrial Estate, Eastern Avenue
    LU5 4JY Dunstable
    Psl Group
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione5373856
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    XYZ 123 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal assignment
    Creato il 01 apr 2009
    Consegnato il 16 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance for the purchase of debts includes any discounting allowances the benefit of all the other provisions of the contract and all securities but only in respect of that credit balance (the contract monies) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 14 ago 2008
    Consegnato il 16 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 16 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 14 ago 2008
    Consegnato il 16 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 16 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008
    Debenture
    Creato il 25 apr 2008
    Consegnato il 09 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 15 giu 2005
    Consegnato il 23 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 15 set 1994
    Consegnato il 16 set 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit b caxton centre porters wood st albans herts. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1988
    Consegnato il 09 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H interest of unit 10 colne way court,colne way,watford,hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1988Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 giu 1984
    Consegnato il 19 giu 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1984Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0