DORMANT WMS 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DORMANT WMS 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01062809 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DORMANT WMS 2 LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova DORMANT WMS 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Craiglas House Maerdy Industrial Estate NP22 5PY Rhymney, Tredegar Gwent |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DORMANT WMS 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FAMILY PLANNING SALES LIMITED | 26 lug 1972 | 26 lug 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DORMANT WMS 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per DORMANT WMS 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Leslie Deacon il 15 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Redmond Mcevoy il 15 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Conor Francis Costigan il 15 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mag 2015 al 31 mar 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 31 mag 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Frank Armstrong come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William Armstrong come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Hamer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di David Frank Armstrong come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Leslie Deacon come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Conor Francis Costigan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Redmond Mcevoy come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed family planning sales LIMITED\certificate issued on 28/11/13 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DORMANT WMS 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTIGAN, Conor Francis | Amministratore | Leopardstown Road Foxrock Dublin 18 Dcc House Leinster Ireland | Ireland | Irish | 143611730017 | |||||
| DEACON, Leslie | Amministratore | Leopardstown Road Foxrock Dublin 18 Dcc House Leinster Ireland | Ireland | Irish | 188311390002 | |||||
| MCEVOY, Redmond | Amministratore | Leopardstown Road Foxrock Dublin 18 Dcc House Leinster Ireland | Ireland | Irish | 152703040007 | |||||
| ARMSTRONG, William | Segretario | Craiglas House Maerdy Industrial Estate NP22 5PY Rhymney, Tredegar Gwent | 161970690001 | |||||||
| BOWSER, Helen Glenys | Segretario | 11 Egerton Road OX10 0HL Wallingford Oxfordshire | British | 62058400001 | ||||||
| CLARKE, Kevin Patrick | Segretario | 28 Crail View GL54 3QH Northleach Gloucestershire | British | 74268640001 | ||||||
| GIBBONS, John Patrick | Segretario | 45 Park Mount AL5 3AS Harpenden Hertfordshire | British | 72851390001 | ||||||
| JONES, Huw Wyndham Lloyd | Segretario | Larchfield House Pregge Lane NP8 1SE Crickhowell Powys | British | 65145590002 | ||||||
| KERR, Vincent Brian | Segretario | The Folly Whitebrook NP25 4TU Monmouth Gwent | British | 122160340001 | ||||||
| MULCAHY, Patrick John | Segretario | 2 Trinity Lane Caerleon NP18 3SZ Newport Gwent | British | 58034380001 | ||||||
| SNOW, Gordon | Segretario | 91 Ferry Road OX3 0EX Oxford Oxfordshire | British | 116227430001 | ||||||
| WILLIAMS, Robin Vaughan | Segretario | Craiglas House Talybont On Usk LD3 7YU Brecon Powys | British | 56290860001 | ||||||
| ARMSTRONG, David Frank | Amministratore | Brewery Road Stillorgan Dcc House Co. Dublin Ireland | England | British | 149576040001 | |||||
| CLARKE, Kevin Patrick | Amministratore | 28 Crail View GL54 3QH Northleach Gloucestershire | British | 74268640001 | ||||||
| COX, Robert Lewis | Amministratore | 75 High Street Prestwood HP16 9EJ Great Missenden Buckinghamshire | British | 87723650001 | ||||||
| DUNN, Steve | Amministratore | 39 Leam Terrace CV31 1BQ Royal Leamington Spa Florence House | England | British | 138547030001 | |||||
| GIBBONS, John Patrick | Amministratore | 45 Park Mount AL5 3AS Harpenden Hertfordshire | British | 72851390001 | ||||||
| GORDON-PICKING, Bruce | Amministratore | 71 Ambler Road Finsbury Park N4 2QS London | British | 49988380006 | ||||||
| HAMER, Hugh Lloyd | Amministratore | Craiglas House Maerdy Industrial Estate NP22 5PY Rhymney, Tredegar Gwent | Wales | British | 164602910001 | |||||
| HARRIES, Michael C | Amministratore | 2 Lippiatt Lane Shipham BS25 1QZ Winscombe Avon | British | 30954160001 | ||||||
| JONES, Huw Wyndham Lloyd | Amministratore | Larchfield House Pregge Lane NP8 1SE Crickhowell Powys | Wales | British | 65145590002 | |||||
| KERR, Vincent Brian | Amministratore | Folly House Whitebrook NP25 4TU Monmouth Gwent | Wales | British | 68341340001 | |||||
| KNIGHT, Nigel | Amministratore | 36 Bushbys Park L37 2EF Liverpool Merseyside | British | 115578040001 | ||||||
| LICKISS, Michael Gillam, Sir | Amministratore | The Old Vicarage Drayton TA10 0JX Langport Somerset | British | 39844600001 | ||||||
| MASSEY, Doreen Elizabeth, Baroness | Amministratore | 66 Lessar Avenue SW4 9HQ London | British | 68771040001 | ||||||
| MORGAN, Janice | Amministratore | 40 Southwood Avenue N6 5RZ London | British | 30954180001 | ||||||
| MULCAHY, Patrick John | Amministratore | 2 Trinity Lane Caerleon NP18 3SZ Newport Gwent | United Kingdom | British | 58034380001 | |||||
| PARKER, Colin George | Amministratore | 6 Strafford Way OX9 3XX Thame Oxfordshire | United Kingdom | British | 36526820001 | |||||
| RAYWOOD, John | Amministratore | 32a West Hill Avenue KT19 8JU Epsom Surrey | United Kingdom | British | 78273100001 | |||||
| ROBERTSON, David Eric, Dr | Amministratore | The Old Shippon Bradley Hall Frodsham WA6 7EP Warrington Cheshire | England | British | 11733090001 | |||||
| SNOW, Gordon | Amministratore | 91 Ferry Road OX3 0EX Oxford Oxfordshire | British | 116227430001 | ||||||
| WEYMAN, Anne Judith | Amministratore | 8 College Cross N1 1PP London | England | British | 8401940001 | |||||
| WILLIAMS, Robin Vaughan | Amministratore | Craiglas House Talybont On Usk LD3 7YU Brecon Powys | British | 56290860001 |
DORMANT WMS 2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 10 mar 2005 Consegnato il 18 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 12 dic 2002 Consegnato il 23 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 lug 1997 Consegnato il 18 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of the company to the chargee contained in the terms of a lease and the rent deposit deed | |
Brevi particolari The sum of £8,300. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 feb 1997 Consegnato il 19 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold premises 28 and 30 kelburne road, cowley, oxford and all the undertaking property assets and rights including uncalled capital and book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 ott 1994 Consegnato il 19 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 ago 1990 Consegnato il 21 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 30 kelburne road, cowley, oxford, oxfordshire t/n on 51016. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0