DORMANT WMS 2 LIMITED

DORMANT WMS 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDORMANT WMS 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01062809
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DORMANT WMS 2 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DORMANT WMS 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DORMANT WMS 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAMILY PLANNING SALES LIMITED26 lug 197226 lug 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di DORMANT WMS 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per DORMANT WMS 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Deacon il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Redmond Mcevoy il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Conor Francis Costigan il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 05 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2015

    Stato del capitale al 06 ago 2015

    • Capitale: GBP 8
    SH01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mag 2015 al 31 mar 2015

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 31 mag 2014

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di David Frank Armstrong come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2014

    Stato del capitale al 06 ago 2014

    • Capitale: GBP 8
    SH01

    Cessazione della carica di William Armstrong come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Hugh Hamer come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di David Frank Armstrong come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Leslie Deacon come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Conor Francis Costigan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Redmond Mcevoy come amministratore

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2013

    3 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed family planning sales LIMITED\certificate issued on 28/11/13
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 nov 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 nov 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 05 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 ago 2013

    SH01

    Chi sono gli amministratori di DORMANT WMS 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSTIGAN, Conor Francis
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrish143611730017
    DEACON, Leslie
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrish188311390002
    MCEVOY, Redmond
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrish152703040007
    ARMSTRONG, William
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Segretario
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    161970690001
    BOWSER, Helen Glenys
    11 Egerton Road
    OX10 0HL Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    11 Egerton Road
    OX10 0HL Wallingford
    Oxfordshire
    British62058400001
    CLARKE, Kevin Patrick
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    Segretario
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    British74268640001
    GIBBONS, John Patrick
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    British72851390001
    JONES, Huw Wyndham Lloyd
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    Segretario
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    British65145590002
    KERR, Vincent Brian
    The Folly
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    Segretario
    The Folly
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    British122160340001
    MULCAHY, Patrick John
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    Segretario
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    British58034380001
    SNOW, Gordon
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    British116227430001
    WILLIAMS, Robin Vaughan
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    Segretario
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    British56290860001
    ARMSTRONG, David Frank
    Brewery Road
    Stillorgan
    Dcc House
    Co. Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Brewery Road
    Stillorgan
    Dcc House
    Co. Dublin
    Ireland
    EnglandBritish149576040001
    CLARKE, Kevin Patrick
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    Amministratore
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    British74268640001
    COX, Robert Lewis
    75 High Street
    Prestwood
    HP16 9EJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    75 High Street
    Prestwood
    HP16 9EJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    British87723650001
    DUNN, Steve
    39 Leam Terrace
    CV31 1BQ Royal Leamington Spa
    Florence House
    Amministratore
    39 Leam Terrace
    CV31 1BQ Royal Leamington Spa
    Florence House
    EnglandBritish138547030001
    GIBBONS, John Patrick
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    British72851390001
    GORDON-PICKING, Bruce
    71 Ambler Road
    Finsbury Park
    N4 2QS London
    Amministratore
    71 Ambler Road
    Finsbury Park
    N4 2QS London
    British49988380006
    HAMER, Hugh Lloyd
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Amministratore
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    WalesBritish164602910001
    HARRIES, Michael C
    2 Lippiatt Lane
    Shipham
    BS25 1QZ Winscombe
    Avon
    Amministratore
    2 Lippiatt Lane
    Shipham
    BS25 1QZ Winscombe
    Avon
    British30954160001
    JONES, Huw Wyndham Lloyd
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    Amministratore
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    WalesBritish65145590002
    KERR, Vincent Brian
    Folly House
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Folly House
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    WalesBritish68341340001
    KNIGHT, Nigel
    36 Bushbys Park
    L37 2EF Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    36 Bushbys Park
    L37 2EF Liverpool
    Merseyside
    British115578040001
    LICKISS, Michael Gillam, Sir
    The Old Vicarage
    Drayton
    TA10 0JX Langport
    Somerset
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Drayton
    TA10 0JX Langport
    Somerset
    British39844600001
    MASSEY, Doreen Elizabeth, Baroness
    66 Lessar Avenue
    SW4 9HQ London
    Amministratore
    66 Lessar Avenue
    SW4 9HQ London
    British68771040001
    MORGAN, Janice
    40 Southwood Avenue
    N6 5RZ London
    Amministratore
    40 Southwood Avenue
    N6 5RZ London
    British30954180001
    MULCAHY, Patrick John
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    Amministratore
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    United KingdomBritish58034380001
    PARKER, Colin George
    6 Strafford Way
    OX9 3XX Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    6 Strafford Way
    OX9 3XX Thame
    Oxfordshire
    United KingdomBritish36526820001
    RAYWOOD, John
    32a West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    Surrey
    Amministratore
    32a West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish78273100001
    ROBERTSON, David Eric, Dr
    The Old Shippon
    Bradley Hall Frodsham
    WA6 7EP Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Shippon
    Bradley Hall Frodsham
    WA6 7EP Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish11733090001
    SNOW, Gordon
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    British116227430001
    WEYMAN, Anne Judith
    8 College Cross
    N1 1PP London
    Amministratore
    8 College Cross
    N1 1PP London
    EnglandBritish8401940001
    WILLIAMS, Robin Vaughan
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    Amministratore
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    British56290860001

    DORMANT WMS 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 mar 2005
    Consegnato il 18 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 lug 1997
    Consegnato il 18 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee contained in the terms of a lease and the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The sum of £8,300.
    Persone aventi diritto
    • Taylor Woodroww Property Company Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 19 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold premises 28 and 30 kelburne road, cowley, oxford and all the undertaking property assets and rights including uncalled capital and book debts.
    Persone aventi diritto
    • The Family Planning Association
    Transazioni
    • 19 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 1994
    Consegnato il 19 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 1990
    Consegnato il 21 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    30 kelburne road, cowley, oxford, oxfordshire t/n on 51016.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0