STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED

STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01064254
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STANLEY GIBBONS PUBLICATIONS LIMITED04 ago 197204 ago 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    1 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    1 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Keith Andrew Millar Heddle come amministratore in data 08 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Martin Werner Peterlechner come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 010642540008 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2016

    Stato del capitale al 22 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    1 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Other company business 30/09/2015
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 010642540008, creata il 01 ott 2015

    8 pagineMR01

    Nomina di Mr Anthony Michael Gee come amministratore in data 16 mar 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Martin Werner Peterlechner come amministratore in data 16 mar 2015

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed stanley gibbons publications LIMITED\certificate issued on 13/02/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name13 feb 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 feb 2015

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2015

    Stato del capitale al 19 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 dic 2013

    Stato del capitale al 31 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2013 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURKIS, Richard Kenneth
    Chiswell House Shernden Lane
    Marsh Green
    TN8 5PR Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Chiswell House Shernden Lane
    Marsh Green
    TN8 5PR Edenbridge
    Kent
    British50467140001
    GEE, Anthony Michael
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Amministratore
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    United KingdomBritish181780820001
    PURKIS, Richard Kenneth
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Amministratore
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    EnglandBritish50467140001
    PANDIT, Arvind Jivanlal
    33 Oak Vale
    West End
    SO30 3SE Southampton
    Hampshire
    Segretario
    33 Oak Vale
    West End
    SO30 3SE Southampton
    Hampshire
    British4791360001
    DUNNINGHAM, Timothy
    Avranches Farm La Ruette D`Avranches
    St Lawrence
    JE3 1GJ Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Avranches Farm La Ruette D`Avranches
    St Lawrence
    JE3 1GJ Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritish58978030001
    FRASER, Paul Ian
    222 Cheltenham Road
    BS6 5QU Bristol
    Avon
    Amministratore
    222 Cheltenham Road
    BS6 5QU Bristol
    Avon
    British5342100001
    GRODECKI, Antony Richard Jan
    The Maltings Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Maltings Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    British42800860002
    HALL, Michael Robert Montague
    Doyle Court
    Doyle Road St Peter Port
    GY1 1RD Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Doyle Court
    Doyle Road St Peter Port
    GY1 1RD Guernsey
    Channel Islands
    British74643910002
    HEDDLE, Keith Andrew Millar
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Amministratore
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    EnglandBritish164474410001
    HENLEY, Mark David
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Amministratore
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    EnglandBritish52315890005
    MCQUILLAN, Anthony Michael
    Church Lodge Station Road
    Wrington
    BS40 5LG Bristol
    Avon
    Amministratore
    Church Lodge Station Road
    Wrington
    BS40 5LG Bristol
    Avon
    Irish22631310001
    NORTHCOTE, Stuart Lionel Barry
    8 Teasel Way Oak Lodge
    West Moors
    BH22 0PQ Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    8 Teasel Way Oak Lodge
    West Moors
    BH22 0PQ Ferndown
    Dorset
    EnglandBritish5448110001
    PANDIT, Arvind Jivanlal
    33 Oak Vale
    West End
    SO30 3SE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    33 Oak Vale
    West End
    SO30 3SE Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish4791360001
    PETERLECHNER, Martin Werner
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    Amministratore
    399 Strand
    London
    WC2R 0LX
    EnglandBritish195983000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    06 apr 2016
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01124806
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    STANLEY GIBBONS ECOMMERCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ott 2015
    Consegnato il 09 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 ott 1993
    Consegnato il 27 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Conditions of sale
    Creato il 05 apr 1993
    Consegnato il 10 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1899.18 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The goods supplied as listed on invoice.
    Persone aventi diritto
    • Kingsmill Paper Company
    Transazioni
    • 10 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 set 1989
    Consegnato il 22 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 giu 1986
    Consegnato il 17 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or the companies (as defined) to the chargee under the terms of thecharge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nord Banren
    Transazioni
    • 17 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee and debenture
    Creato il 29 ott 1984
    Consegnato il 16 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 giu 1982
    Consegnato il 12 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,759000 and all other monies due or to become due from stanley gibbons internatinal limited to the chargee under a share sales agreement of a 25.6.1982
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & debts uncalled capital, with all buildings, fitxtues, fixed plant & machinery (see doc M37 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Letraset Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 giu 1982
    Consegnato il 09 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capotal. With all buildings fixtures (ind. Trede fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0