ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01065384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FTMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED01 mar 199501 mar 1995
    FMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED14 ago 199214 ago 1992
    FORWARD TRUST CAR LEASING LIMITED08 gen 199208 gen 1992
    ASSETPURCHASE LIMITED18 ago 198618 ago 1986
    COLSHIRE LIMITED11 ago 197211 ago 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 dic 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Canada Square London E14 5HQ a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 31 dic 2019

    2 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Okechukwu Uwakwe il 17 lug 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    22 pagineAA

    Nomina di Mr. James Richard Hughes come segretario in data 15 ago 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Molly Ranger come segretario in data 15 ago 2019

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Crispin Robert John Irvin il 07 feb 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Miss Molly Ranger come segretario in data 22 mar 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Romana Lewis come segretario in data 08 dic 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Okechukwu Uwakwe come amministratore in data 12 set 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    29 pagineAA

    Seconda presentazione per la nomina di Crispin Robert John Irvin come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Cessazione della carica di John Richard Kent come amministratore in data 31 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUGHES, James Richard, Mr.
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    Segretario
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    261711070001
    IRVIN, Crispin Robert John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish228671160002
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    UWAKWE, Okechukwu
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Level 2
    United Kingdom
    Amministratore
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Level 2
    United Kingdom
    EnglandIrish137525250002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    188917800001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092040001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Segretario
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198529210001
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    RANGER, Molly
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    Segretario
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    245613190001
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Segretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209410001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154912590001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967370001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Amministratore
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Amministratore
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Amministratore
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Amministratore
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Amministratore
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    SENIOR, Carl Thomas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish165728830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26 ott 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione229341
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A first priority honh kong ship mortgage
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 20 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 8,063 teu container vellse with official number hk-1900 names "oocl southampton".
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Creato il 08 gen 2007
    Consegnato il 15 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 99,705.6 dwt vessel with hull number 1569 registered at the hong kong shipping registry with official number hk-1806 under the name oocl europe. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 25 gen 2005
    Consegnato il 27 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1570 registered or to be registered under the hong kong flag and includes any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 27 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 25 gen 2005
    Consegnato il 27 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1569 registered or to be registered under the hong kong flag and including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 27 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Creato il 11 mag 2004
    Consegnato il 17 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl ningbo registered in the hong kong register of ships with official number hk-1200 (the vessel).
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 17 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second deed of covenant
    Creato il 15 apr 2004
    Consegnato il 19 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1427 and to be named oocl ningbo and registered or to be registered under the hong kong flag including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • 22 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second deed of covenant
    Creato il 15 apr 2004
    Consegnato il 19 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 99,500 dwt container vessel named oocl qingdao and rgeistered under the hong kong flag with official number hk-1199 and call sign VRZL2 including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Creato il 07 apr 2004
    Consegnato il 14 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl qingdao registered in the hong kong register of ships with official number hk-1199.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2019Inizio della liquidazione
    12 mag 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0