HAWKINS PLANT

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAWKINS PLANT
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 01065554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAWKINS PLANT?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HAWKINS PLANT?

    Indirizzo della sede legale
    The Grange 2 Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAWKINS PLANT?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAWKINS PLANT HIRE LIMITED02 apr 198402 apr 1984
    CHARLES HAWKINS & SONS(CONTRACTORS)LIMITED11 ago 197211 ago 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAWKINS PLANT?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HAWKINS PLANT?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Alan Arthur Nixon come segretario in data 06 dic 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Alan Arthur Nixon come amministratore in data 15 feb 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Charleston House Cruckmoor Lane Prees Green Whitchurch Shropshire SY13 2BS a The Grange 2 Aston Street Wem Shrewsbury SY4 5AY in data 04 set 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 dic 2015

    Stato del capitale al 01 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2014

    Stato del capitale al 04 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2013

    Stato del capitale al 10 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HAWKINS PLANT?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAWKINS, Janette Helen
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Amministratore
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    United KingdomBritish37309220001
    BURNS, Christopher
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    Irish66007600001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Segretario
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    British67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Segretario
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    British2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British5179100002
    STOTT, Christopher
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    Segretario
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    British84131830001
    WYCHERLEY, Sian Mair
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    Segretario
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    British60690570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ATKINSON, Ralph
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    Amministratore
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    British82227730001
    BISH, Andrew Brandon
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    Amministratore
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    United KingdomBritish87360330001
    BLACKBURN, Robert Paul
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    Amministratore
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    EnglandBritish181188220001
    BONGARTEN, Karl James
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    American59693970001
    CAMERON, Richard Alexander
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    British16715040001
    DODDRELL, Paul Derek
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    Amministratore
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    British74659020001
    EDWARDS, David
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    Amministratore
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    British74658940003
    FANELLI, Tom Francis
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    American59691400001
    HAWKINS, Charles Barry Kitley
    SY4
    Amministratore
    SY4
    United KingdomBritish39331910001
    HAWKINS, Charles Ernest Kitley
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    British2938910001
    HAWKINS, Evelyn Melrose
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    British2938870001
    HAWKINS, Michael Edward Ernest
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Amministratore
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    United KingdomBritish188706610001
    JACOBS, Christopher
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    Amministratore
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    American47655500001
    JONES, Frank Douglas
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish53180400001
    LITTLES, Carolyn Sue
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    American59691910001
    MATTHEW, Jeremy
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    Amministratore
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    British And Canadian115291490001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Amministratore
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    United KingdomBritish67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Amministratore
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    British2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British5179100002
    SHUTT, Beverly Vincent
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    Amministratore
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    English34374060001
    SMITH, Gary John
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish24872600001
    SMITH, Peter Leslie
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    British88329890001
    THOMPSON, Brian
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish17395050002
    WILLIAMS, Robert Clive
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    Amministratore
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    British2938890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAWKINS PLANT?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aarco 287 Limited
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    06 apr 2016
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEndland And Wales
    Numero di registrazione6144291
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HAWKINS PLANT ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 dic 1995
    Consegnato il 20 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1993
    Consegnato il 31 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 1992
    Consegnato il 13 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Floating charge over all assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 set 1990
    Consegnato il 03 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The depot on the north west side of mold road buckley, clwyd title no wa 55216.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease purchase agreement
    Creato il 29 giu 1987
    Consegnato il 03 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease purchase agreement.
    Brevi particolari
    All insurance policies whatsoever in respect of items of equipment (see form 395 for full details) and all the benefits thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lefac International Sa
    Transazioni
    • 03 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 apr 1984
    Consegnato il 19 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ago 1983
    Consegnato il 08 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or charles hawkins & sons (tractors and machinery) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1982
    Consegnato il 09 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at loppington 1.713 acres shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1981
    Consegnato il 29 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H grange farm loppington wem shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1981
    Consegnato il 29 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the old cheese store ellesmere road wem shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1981
    Consegnato il 19 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings and trade fixtures including fixed p & m thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1981
    Consegnato il 18 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at loppington shropshire being no 166 on the O.S. map for the area.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 17 set 1980
    Consegnato il 25 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises being grange farm, loppington, wem, shropshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Irrevocable authority to messrs graham withers & co evidencing equitable assignment of property
    Creato il 12 mag 1980
    Consegnato il 19 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land and premises being grange farm loppington, wem, shropshire together with all fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0