HAPPY EATER LIMITED

HAPPY EATER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAPPY EATER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01065868
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAPPY EATER LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova HAPPY EATER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAPPY EATER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per HAPPY EATER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 apr 2010

    • Capitale: GBP 755,049
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 12 mag 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    17 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Guy Paul Cuthbert Parsons il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Victor Harvey il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Grant David Hearn il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jon William Mortimore il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Jon William Mortimore il 03 feb 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di HAPPY EATER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Segretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish88628480002
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish102187770002
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British49678170001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Segretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Segretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Segretario
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Segretario
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Segretario
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    WILSON, Paul James
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    Segretario
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    British767650001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Segretario
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    CHIANDETTI, Gian Battista
    Daneswood
    Monks Walk
    SL5 9AZ South Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Daneswood
    Monks Walk
    SL5 9AZ South Ascot
    Berkshire
    Italian35071680001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish49678170001
    FORTE, Rocco Giovanni, Sir
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    Amministratore
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    United KingdomBritish2725010001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Amministratore
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Amministratore
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    MONNICKENDAM, Anthony Louis
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish1013880003
    SMITH, Anthony Roger
    17 Campion Way
    Hartley Wintney
    RG27 8TL Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    17 Campion Way
    Hartley Wintney
    RG27 8TL Basingstoke
    Hampshire
    British47694550001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Amministratore
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish37564540001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Amministratore
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001
    FORTE (UK) LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Amministratore
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42204690001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005

    HAPPY EATER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1980
    Consegnato il 02 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at haldon moor, kennford, devon title no:- dn 89280. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 25 mar 1980
    Consegnato il 28 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land adjoining camel cross garage west camel somerset comprised in an assignment dated 12/3/80. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1980
    Consegnato il 26 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings known as happy easter restaurant, herstridge, templecombe, somerset, & comprised in a conveyance dated 22/4/74. together with fixed & moveable plant & machinery, fixtures, furniture, implements & utensils & all buildings controls for the repair, alteration or development thereof. Except for that part of the said land described in a conveyance dated 8/1/75.
    Transazioni
    • 26 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 08 feb 1980
    Consegnato il 22 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The post boys cafe, flimwell, kent. Title no k 367652.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 1980
    Consegnato il 14 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The cosy cornor cafe, brighton road, hooley, surrey. Title nos:- sy 472 158 and sy 472195. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1979
    Acquisito il 31 mar 1980
    Consegnato il 02 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £70,000
    Brevi particolari
    F/H land & premises being land at haldon moor, kenford, devon as described in a transfer dated 11/5/79.
    Persone aventi diritto
    • V.W. Coulter
    • C.A. Coulter
    Transazioni
    • 02 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1978
    Consegnato il 28 dic 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the west side, of the road leading from london to brighton & ugham parish title no wsk 3363. and or placed upon the property and all building contracts for repair alteration or development thereof.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Brown Shipley & Co. LTD.
    Transazioni
    • 28 dic 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 24 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0