IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01066778 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
- Amministrazione dei mercati finanziari (66110) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Gresham Street EC2V 7BX London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| IFG LIFE & PENSIONS LIMITED | 01 mag 1997 | 01 mag 1997 |
| D.N. SLATER ASSOCIATES LIMITED | 18 ago 1972 | 18 ago 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Kathryn Elizabeth Purves come amministratore in data 04 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Andrew Beale come amministratore in data 04 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Vinotha Kamala Anthony come segretario in data 24 gen 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Annette Rodriguez come segretario in data 23 gen 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Clifford Spencer Jones come amministratore in data 31 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lisa Annette Rodriguez come segretario in data 01 gen 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Clifford Spencer Jones come segretario in data 31 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Trinity House Anderson Road Swavesey Cambridgeshire CB24 4UQ a 1 Gresham Street London EC2V 7BX in data 03 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Mary Gangemi come amministratore in data 14 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni di un revisore | 2 pagine | AA03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Clifford Spencer Jones come amministratore in data 07 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY, Vinotha Kamala | Segretario | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | 242845200001 | |||||||
| GANGEMI, Mary | Amministratore | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | United Kingdom | Australian,British | 220973260001 | |||||
| PURVES, Kathryn Elizabeth | Amministratore | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | United Kingdom | British | 98017050003 | |||||
| BURGON, Terence | Segretario | 32a Mill Road Buckden PE18 9SS Huntingdon Cambridgeshire | British | 3508630001 | ||||||
| ELSTUB, John Peter | Segretario | 20 Blenheim Drive St Ives PE17 6UW Huntingdon Cambridgeshire | British | 39253950001 | ||||||
| FAIRHURST, Susan Joanna | Segretario | 29 Ennerdale Close PE29 6UU Huntingdon Cambridgeshire | British | 69824430001 | ||||||
| FRY, Jonathan Edward Leighton | Segretario | 4 Romney Close St Ives PE27 3HB Huntingdon Cambridgeshire | British | 47278320001 | ||||||
| JONES, Clifford Spencer | Segretario | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | 196538620001 | |||||||
| MOORE, Nigel John | Segretario | 18 Doddenhill Close CB10 2EQ Saffron Walden Essex | British | 52716000001 | ||||||
| RODRIGUEZ, Lisa Annette | Segretario | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | 221610980001 | |||||||
| SLATER, David Norman | Segretario | The White House 250 Thorpe Road PE3 6LW Peterborough Cambridgeshire | British | 16975330001 | ||||||
| WATSON, John Anderson Scotland | Segretario | Laxton Grange PE28 3XU Bluntisham 9 Cambridgeshire United Kingdom | British | 81703720005 | ||||||
| BEALE, Richard Andrew | Amministratore | 23 Church Street PE7 3RF Stilton Cambridgeshire | United Kingdom | British | 107280260002 | |||||
| BOGARD, Mark Alexander | Amministratore | Flat 1 11 Eton Avenue NW3 3EL London | England | British | 101849780001 | |||||
| BUCKSEY, Paul Martin | Amministratore | 20 Malthouse Lane Ramsey PE26 1SQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 68497900001 | ||||||
| BURGON, Terence | Amministratore | 32a Mill Road Buckden PE18 9SS Huntingdon Cambridgeshire | British | 3508630001 | ||||||
| DAWSON, Eldon Stevenson | Amministratore | Carrara Cottage High Street Rattlesden IP30 0SB Bury St Edmunds Suffolk | Irish | 31390340001 | ||||||
| DEW, Douglas | Amministratore | 21 Scrolans St Ives PE17 4SF Huntingdon Cambridgeshire | British | 62029210001 | ||||||
| FRY, Jonathan Edward Leighton | Amministratore | 4 Romney Close St Ives PE27 3HB Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 47278320001 | |||||
| GEESON, Christopher John | Amministratore | 12 Mill Quay London Road PE27 5GT St Ives Cambridgeshire | British | 103783860001 | ||||||
| HAYES, Richard George | Amministratore | Truddor Grange Newtownmountkennedy Co Wicklow IRISH Ireland | Ireland | Irish | 168730590001 | |||||
| JONES, Clifford Spencer | Amministratore | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | United Kingdom | British | 105862690002 | |||||
| LYNCH, Donal | Amministratore | 271 The Meadows West Belgard Heights IRISH Dublin 24 | British | 80709680001 | ||||||
| MOORE, Nigel John | Amministratore | 18 Doddenhill Close CB10 2EQ Saffron Walden Essex | British | 52716000001 | ||||||
| PEMBERTON, Jonathan Adam | Amministratore | 20 Orchard Road Melbourn SG8 6HL Royston Hertfordshire | British | 52894880001 | ||||||
| RHODES, Roger Philip | Amministratore | School House Mill Street Houghton PE17 2AZ Huntingdon Cambridgeshire | British | 67428610001 | ||||||
| SARGISSON, Timothy Charles | Amministratore | Jaspers Cottage Patmore Heath SG11 2LY Albury Hertfordshire | United Kingdom | British | 80406220002 | |||||
| SIMONS, Peter | Amministratore | 57 Speldhurst Road W4 1BY London | England | Irish | 81901620001 | |||||
| SLATER, David Norman | Amministratore | The White House 250 Thorpe Road PE3 6LW Peterborough Cambridgeshire | British | 16975330001 | ||||||
| WATSON, John Anderson Scotland | Amministratore | Laxton Grange PE28 3XU Bluntisham 9 Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81703720005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifg Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Buckingway Business Park, Anderson Road Swavesey CB24 4UQ Cambridge Trinity House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and charge | Creato il 01 giu 2001 Consegnato il 19 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to the chargee | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all estates or interests in the freehold,leasehold and other immovable property known as unit 2,plot 6,buckingham business park swavesey cambridgeshire the entire plot 6 being registered under title number CB232038 and the rent and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to or charged to the chargor by way of first fixed charge all plant and machinery owned by the chargor both present and future situated on or at the legally mortgaged property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 09 apr 2001 Consegnato il 21 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari First legal mortgage over all estates or interests in the freehold,leasehold and other immovable property known as (a) berkley jacobs house,laser quay development,culpeper close,frindsbury,rochester,kent; t/no K694238; (b) 54 queen anne street and 10A marylebone mews,st.marylebone,westminster,london; t/no LN127901; all rent and the proceeds of sale thereof and all buildings,trade and other fixtures thereon; first fixed charge over all right,title,interest and benefit to and under the contract to purchase the property known as unit 2,plot 6,buckingham business park,swavesey,cambridgeshire t/n CB232038; all fixed plant machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 ott 1999 Consegnato il 08 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The sum of £1,500,000.00. all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari The leasehold property situated at 54 queen anne street and 10A marylebone mews london W.1. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on renewal commission | Creato il 30 dic 1997 Consegnato il 08 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari The renewal commission received by the company/businesses carried on by santhouse whittington consulting actuaries, santhouse whittington (documentation services), santhouse whittington financial services limited and or santhouse whittington (documentation and computer adminsitration) limited arising agencies listed in the share acquisition agreement dated 7 november 1997. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 06 feb 1997 Consegnato il 20 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Floating cjharge all undertaking property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 09 nov 1989 Consegnato il 16 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from david norman slater and carol slater(as trustees of the dns pension scheme) to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari F/Hold property k/as unit b meadow lane,st. Ives, cambridgeshire. Title no. Cb 102481 together with all buildings & fixtures thereon. Assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 09 nov 1989 Consegnato il 16 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property k/as unit b meadow lane, st. Ives, cambridgeshire. Title no. Cb 102481 together with all buildings & fixtures thereon. Assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 07 nov 1988 Consegnato il 19 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Office unit at meadow lane, st ives, cambridgeshire assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0