IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED

IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIFG FINANCIAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01066778
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    • Amministrazione dei mercati finanziari (66110) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IFG LIFE & PENSIONS LIMITED01 mag 199701 mag 1997
    D.N. SLATER ASSOCIATES LIMITED18 ago 197218 ago 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    14 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mrs Kathryn Elizabeth Purves come amministratore in data 04 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Andrew Beale come amministratore in data 04 apr 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Nomina di Mrs Vinotha Kamala Anthony come segretario in data 24 gen 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lisa Annette Rodriguez come segretario in data 23 gen 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Clifford Spencer Jones come amministratore in data 31 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Lisa Annette Rodriguez come segretario in data 01 gen 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Clifford Spencer Jones come segretario in data 31 dic 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Trinity House Anderson Road Swavesey Cambridgeshire CB24 4UQ a 1 Gresham Street London EC2V 7BX in data 03 gen 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Mary Gangemi come amministratore in data 14 dic 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Clifford Spencer Jones come amministratore in data 07 apr 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANTHONY, Vinotha Kamala
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    242845200001
    GANGEMI, Mary
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    United KingdomAustralian,British220973260001
    PURVES, Kathryn Elizabeth
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    United KingdomBritish98017050003
    BURGON, Terence
    32a Mill Road Buckden
    PE18 9SS Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    32a Mill Road Buckden
    PE18 9SS Huntingdon
    Cambridgeshire
    British3508630001
    ELSTUB, John Peter
    20 Blenheim Drive
    St Ives
    PE17 6UW Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    20 Blenheim Drive
    St Ives
    PE17 6UW Huntingdon
    Cambridgeshire
    British39253950001
    FAIRHURST, Susan Joanna
    29 Ennerdale Close
    PE29 6UU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    29 Ennerdale Close
    PE29 6UU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British69824430001
    FRY, Jonathan Edward Leighton
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    British47278320001
    JONES, Clifford Spencer
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    196538620001
    MOORE, Nigel John
    18 Doddenhill Close
    CB10 2EQ Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    18 Doddenhill Close
    CB10 2EQ Saffron Walden
    Essex
    British52716000001
    RODRIGUEZ, Lisa Annette
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    221610980001
    SLATER, David Norman
    The White House 250 Thorpe Road
    PE3 6LW Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    The White House 250 Thorpe Road
    PE3 6LW Peterborough
    Cambridgeshire
    British16975330001
    WATSON, John Anderson Scotland
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    British81703720005
    BEALE, Richard Andrew
    23 Church Street
    PE7 3RF Stilton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    23 Church Street
    PE7 3RF Stilton
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish107280260002
    BOGARD, Mark Alexander
    Flat 1 11 Eton Avenue
    NW3 3EL London
    Amministratore
    Flat 1 11 Eton Avenue
    NW3 3EL London
    EnglandBritish101849780001
    BUCKSEY, Paul Martin
    20 Malthouse Lane
    Ramsey
    PE26 1SQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    20 Malthouse Lane
    Ramsey
    PE26 1SQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British68497900001
    BURGON, Terence
    32a Mill Road Buckden
    PE18 9SS Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    32a Mill Road Buckden
    PE18 9SS Huntingdon
    Cambridgeshire
    British3508630001
    DAWSON, Eldon Stevenson
    Carrara Cottage High Street
    Rattlesden
    IP30 0SB Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Carrara Cottage High Street
    Rattlesden
    IP30 0SB Bury St Edmunds
    Suffolk
    Irish31390340001
    DEW, Douglas
    21 Scrolans
    St Ives
    PE17 4SF Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    21 Scrolans
    St Ives
    PE17 4SF Huntingdon
    Cambridgeshire
    British62029210001
    FRY, Jonathan Edward Leighton
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    4 Romney Close
    St Ives
    PE27 3HB Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish47278320001
    GEESON, Christopher John
    12 Mill Quay
    London Road
    PE27 5GT St Ives
    Cambridgeshire
    Amministratore
    12 Mill Quay
    London Road
    PE27 5GT St Ives
    Cambridgeshire
    British103783860001
    HAYES, Richard George
    Truddor Grange Newtownmountkennedy
    Co Wicklow
    IRISH Ireland
    Amministratore
    Truddor Grange Newtownmountkennedy
    Co Wicklow
    IRISH Ireland
    IrelandIrish168730590001
    JONES, Clifford Spencer
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7BX London
    1
    England
    United KingdomBritish105862690002
    LYNCH, Donal
    271 The Meadows West
    Belgard Heights
    IRISH Dublin
    24
    Amministratore
    271 The Meadows West
    Belgard Heights
    IRISH Dublin
    24
    British80709680001
    MOORE, Nigel John
    18 Doddenhill Close
    CB10 2EQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    18 Doddenhill Close
    CB10 2EQ Saffron Walden
    Essex
    British52716000001
    PEMBERTON, Jonathan Adam
    20 Orchard Road
    Melbourn
    SG8 6HL Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    20 Orchard Road
    Melbourn
    SG8 6HL Royston
    Hertfordshire
    British52894880001
    RHODES, Roger Philip
    School House
    Mill Street Houghton
    PE17 2AZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    School House
    Mill Street Houghton
    PE17 2AZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British67428610001
    SARGISSON, Timothy Charles
    Jaspers Cottage
    Patmore Heath
    SG11 2LY Albury
    Hertfordshire
    Amministratore
    Jaspers Cottage
    Patmore Heath
    SG11 2LY Albury
    Hertfordshire
    United KingdomBritish80406220002
    SIMONS, Peter
    57 Speldhurst Road
    W4 1BY London
    Amministratore
    57 Speldhurst Road
    W4 1BY London
    EnglandIrish81901620001
    SLATER, David Norman
    The White House 250 Thorpe Road
    PE3 6LW Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The White House 250 Thorpe Road
    PE3 6LW Peterborough
    Cambridgeshire
    British16975330001
    WATSON, John Anderson Scotland
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Laxton Grange
    PE28 3XU Bluntisham
    9
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81703720005

    Chi sono le persone con controllo significativo di IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ifg Uk Holdings Limited
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    England
    06 apr 2016
    Buckingway Business Park, Anderson Road
    Swavesey
    CB24 4UQ Cambridge
    Trinity House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies England & Wales
    Numero di registrazione06033126
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IFG FINANCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and charge
    Creato il 01 giu 2001
    Consegnato il 19 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all estates or interests in the freehold,leasehold and other immovable property known as unit 2,plot 6,buckingham business park swavesey cambridgeshire the entire plot 6 being registered under title number CB232038 and the rent and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to or charged to the chargor by way of first fixed charge all plant and machinery owned by the chargor both present and future situated on or at the legally mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 09 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all estates or interests in the freehold,leasehold and other immovable property known as (a) berkley jacobs house,laser quay development,culpeper close,frindsbury,rochester,kent; t/no K694238; (b) 54 queen anne street and 10A marylebone mews,st.marylebone,westminster,london; t/no LN127901; all rent and the proceeds of sale thereof and all buildings,trade and other fixtures thereon; first fixed charge over all right,title,interest and benefit to and under the contract to purchase the property known as unit 2,plot 6,buckingham business park,swavesey,cambridgeshire t/n CB232038; all fixed plant machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 ott 1999
    Consegnato il 08 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £1,500,000.00. all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The leasehold property situated at 54 queen anne street and 10A marylebone mews london W.1.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank PLC and Ulster Bank Markets Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on renewal commission
    Creato il 30 dic 1997
    Consegnato il 08 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The renewal commission received by the company/businesses carried on by santhouse whittington consulting actuaries, santhouse whittington (documentation services), santhouse whittington financial services limited and or santhouse whittington (documentation and computer adminsitration) limited arising agencies listed in the share acquisition agreement dated 7 november 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sagitas Ag
    • Jane Whittington
    • Reredos Corporation
    • David Whittington
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 06 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Floating cjharge all undertaking property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • Ulster Bank Markets Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 09 nov 1989
    Consegnato il 16 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from david norman slater and carol slater(as trustees of the dns pension scheme) to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as unit b meadow lane,st. Ives, cambridgeshire. Title no. Cb 102481 together with all buildings & fixtures thereon. Assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 nov 1989
    Consegnato il 16 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as unit b meadow lane, st. Ives, cambridgeshire. Title no. Cb 102481 together with all buildings & fixtures thereon. Assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 nov 1988
    Consegnato il 19 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Office unit at meadow lane, st ives, cambridgeshire assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0