WINERITE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WINERITE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01072003 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WINERITE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WINERITE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WINERITE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 08 apr 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per WINERITE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 08 apr 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan David Moxon come amministratore in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Martyn Ronald Ward come amministratore in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Etherington come amministratore in data 13 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony William Reed come amministratore in data 07 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 apr 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 04 apr 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 05 apr 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan David Moxon il 12 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 06 apr 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 07 apr 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Scudder come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Mckelvie come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 apr 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WINERITE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDDER, David | Segretario | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | 165202150001 | |||||||
| REED, Anthony William | Amministratore | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 228995600001 | |||||
| WARD, Martyn Ronald | Amministratore | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 232918140001 | |||||
| COOPER, Colin Thompson | Segretario | 7 Glendale Road RH15 0EJ Burgess Hill West Sussex | British | 127536180001 | ||||||
| MAHONEY, Anthony Denis | Segretario | 65 Stainburn Drive LS17 6LZ Leeds West Yorkshire | British | 4042880001 | ||||||
| MCKELVIE, Andrew Laurence | Segretario | 110 Osborne Road BN1 6LU Brighton East Sussex | British | 60126680002 | ||||||
| MURPHY, Luke | Segretario | Pine Tree Cottage Field Lane, Wistow YO8 3XD Selby | British | 117303130001 | ||||||
| TOMLINSON, Paula Jane | Segretario | 3 Springfield Close Bolney RH17 5PQ Haywards Heath West Sussex | British | 5904620004 | ||||||
| ADAMS, Christopher Borlase | Amministratore | Belmont House East Hoathly BN8 6QJ Lewes East Sussex | United Kingdom | British | 32132270001 | |||||
| ATKINSON, Angela Mary | Amministratore | 61 Main Street Thorner LS14 3BU Leeds West Yorkshire | British | 4226490001 | ||||||
| ATKINSON, Gerald | Amministratore | 61 Main Street Thorner LS14 3BU Leeds West Yorkshire | British | 4042890001 | ||||||
| BELL, Graham | Amministratore | 52 Westgate LS22 6NJ Wetherby West Yorkshire | British | 63749090001 | ||||||
| BELL, Maurice | Amministratore | Barbondale Mill Lane Bardsey LS17 9AN Leeds | British | 63114430001 | ||||||
| CLARKE, Peter Lovat | Amministratore | Brook House Cann Lane South Appleton WA4 5NJ Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 4770530001 | |||||
| ETHERINGTON, Christopher | Amministratore | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | United Kingdom | British | 113997090003 | |||||
| GREEN, Jack | Amministratore | Alston 9 Farnham Lane Ferrensby HG5 9JG Knaresborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 71549080001 | |||||
| GREENWAY, Jason | Amministratore | 73 Imperial Road Marsh HD1 4PG Huddersfield West Yorkshire | British | 116954560001 | ||||||
| HASTINGS, John Arthur | Amministratore | 1a Hill End Road LS12 3PT Leeds Yorkshire | British | 49513880001 | ||||||
| LITTLE, Christopher William | Amministratore | 7 Hoewood Mill Glade Small Dole BN5 9YR Henfield West Sussex | British | 52244990001 | ||||||
| MCPHERSON, Graham Scott | Amministratore | Kingston Barn Kingston Lane BN16 1RP East Preston West Sussex | British | 48929130002 | ||||||
| MOXON, Jonathan David | Amministratore | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 68503410002 | |||||
| MURPHY, Luke | Amministratore | Pine Tree Cottage Field Lane, Wistow YO8 3XD Selby | British | 117303130001 | ||||||
| RIALL, Katharine Elizabeth | Amministratore | Orchard Barn Main Street East Keswick LS17 9EU Leeds West Yorkshire | British | 61070770002 | ||||||
| SIMONS, John Trevor | Amministratore | 5 Cedar Drive LS24 9TJ Tadcaster North Yorkshire | British | 63749250001 | ||||||
| STEVENS, Rodney Hugh Webster | Amministratore | Woodley House 78 Alwoodley Lane LS17 7PT Leeds West Yorkshire | British | 51294160002 | ||||||
| WADE, Derek James | Amministratore | Mottram Moor Farm Mottram Moor Hollingworth SK14 8LZ Hyde Cheshire | British | 46623620001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WINERITE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer & Harvey Mclane Limited | 06 apr 2016 | Davigdor Road BN3 1RE Hove P&H House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WINERITE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Receivables accession deed | Creato il 04 apr 2008 Consegnato il 10 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or any the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 07 feb 2002 Consegnato il 21 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money or liabilities due or to become due from any charging company to the chargee as security trustee for itself and the other secured parties (as defined) (the "security agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of floating charge all its present and future assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 feb 2002 Consegnato il 13 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (the "chargor") or any member of the group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 set 1999 Consegnato il 01 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north side of stanningley road, bramley, west yorkshire t/no: ywe 53360. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 set 1999 Consegnato il 30 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold property being land lying to the north west of gelderd rd,new wortley,leeds,west yorkshire; f/hold property known as land/blds lying on north west side of gelderd rd,leeds,west yorkshire and few other properties listed; t/nos WYK205980,WYK462157,WYK263142,WYK283052,WYK385278,WYK200329. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 set 1999 Consegnato il 29 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 12 gen 1990 Consegnato il 22 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from winerite limited and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 3.316 acres of f/h land & buildings at gelderd road, leeds LS12 floating charge over all movable plant fixtures & fittings machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 05 set 1986 Consegnato il 08 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All momies due or to become due from the company and/or all of the other companies named therein to craven supply limited on any account whatsoever. | |
Brevi particolari L/Hold land at gelderd road. Leeds west yorkshire and all buildings erected thereon, including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 08 ott 1984 Consegnato il 17 ott 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or travrose limited and/or liquor leaders limited to the chargee supplemental to a debenture dated 3RD dec 1973 | |
Brevi particolari 1) f/hold & l/hold property and the fixed plant, machinery trade & other fixtures. 2) all book debts & other debts present & future. 3) goodwill & uncalled capital present & future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 apr 1980 Consegnato il 24 apr 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to be come due from the company to the chargee and/or liquor leaders limited and/or travose limited on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Freehold and leasehold property geldard road and whiteley road new wortley leeds west yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 giu 1974 Consegnato il 14 giu 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at bramley in the city of leeds title ywe 53360. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 dic 1973 Consegnato il 10 dic 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future inculding goodwill uncalled capital. By way of a floating charge (see doc 19). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0