RED DISK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRED DISK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01074154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RED DISK LIMITED?

    • (5540) /

    Dove si trova RED DISK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Clarendon House
    Shenley Road
    WD6 1AG Borehamwood
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RED DISK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PLATINUM LACE TRADING LIMITED08 apr 201008 apr 2010
    GLENDOLA LEISURE LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    GLENDOLA LEISURE LIMITED28 set 197228 set 1972
    GLENDOLA CATERING LIMITED28 set 197228 set 1972
    GLENDOLA CATERING LIMITED28 set 197228 set 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di RED DISK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per RED DISK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Simon Gordon come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Hogarth Close Ealing London W5 2JT United Kingdom in data 30 nov 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Bronwyn Warr come segretario

    2 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 dic 2010

    3 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 ago 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Mrs Bronwyn Jane Warr come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Simon Peter Warr come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 364 High Street Harlington Heathrow Hayes UB3 5LF in data 27 apr 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Graeme Ramsay come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Alfred Bree come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Salussolia come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexander Salussolia come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 26 mar 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 28 mar 2009

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RED DISK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GORDON, Simon
    Shenley Road
    WD6 1AG Borehamwood
    Clarendon House
    Herts
    Segretario
    Shenley Road
    WD6 1AG Borehamwood
    Clarendon House
    Herts
    British156134910001
    WARR, Simon Peter
    Shenley Road
    WD6 1AG Borehamwood
    Clarendon House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Shenley Road
    WD6 1AG Borehamwood
    Clarendon House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish150018210001
    CATLEY, Grahame John
    91 Gloucester Mews West
    W2 6DY London
    Segretario
    91 Gloucester Mews West
    W2 6DY London
    British438280001
    MAYHO, Peter
    Cobbers Ridgeway Close
    GU21 4RD Woking
    Surrey
    Segretario
    Cobbers Ridgeway Close
    GU21 4RD Woking
    Surrey
    British62886900002
    RAMSAY, Graeme John
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    Segretario
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    British133287810001
    VERRALL, Bernard
    Woodside
    3 Brookley Close, Runfold
    GU10 1QF Farnham
    Surrey
    Segretario
    Woodside
    3 Brookley Close, Runfold
    GU10 1QF Farnham
    Surrey
    British112281500001
    WARR, Bronwyn Jane
    Hogarth Close
    W5 2JT Ealing
    3
    London
    United Kingdom
    Segretario
    Hogarth Close
    W5 2JT Ealing
    3
    London
    United Kingdom
    150892280001
    BREE, Alfred
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    Amministratore
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    Dutch60043930002
    COCKMAN, Michael Graham
    156 Kingston Road
    OX2 6RP Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    156 Kingston Road
    OX2 6RP Oxford
    Oxfordshire
    British60043870002
    MACKINLAY, John Douglas
    Melon Park
    Liberty Elie
    KY9 7AU Leven
    Fife
    Amministratore
    Melon Park
    Liberty Elie
    KY9 7AU Leven
    Fife
    British438310006
    RAMSAY, Graeme John
    Hogarth Close
    W5 2JT Ealing
    3
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Hogarth Close
    W5 2JT Ealing
    3
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish64714460003
    RICHARDS, David Paul
    37 Sonia Gardens
    TW5 0LZ Heston
    Amministratore
    37 Sonia Gardens
    TW5 0LZ Heston
    British62607420001
    SALUSSOLIA, Alexander
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    Amministratore
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    EnglandBritish35354750005
    SALUSSOLIA, Peter Nicholas
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    Amministratore
    High Street
    Harlington Heathrow
    UB3 5LF Hayes
    364
    EnglandBritish199902000001
    TINKER, Finlay Thomas Alan
    The Gables 1 Brent Road
    TW8 8BP Brentford
    Middlesex
    Amministratore
    The Gables 1 Brent Road
    TW8 8BP Brentford
    Middlesex
    British438300001

    RED DISK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Amendment deed in respect of a fixed and floating security agreement dated 11 august 2004 and
    Creato il 05 dic 2008
    Consegnato il 12 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of the present and future assets and undertaking of the chargor.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    Transazioni
    • 12 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 04 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property with t/no EGL363145 k/a city pride public house 1 westferry road poplar london.
    Persone aventi diritto
    • Drysea Holdings Corp
    Transazioni
    • 04 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 11 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Joe daflo's commercial road southampton t/n HP272164 floating charge all assets being the goodwill property undertaking rights and revenues.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creato il 11 ago 2004
    Consegnato il 17 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed legal mortgage world's end property situated at 174 camden high street and 1,3 and 5 greenland road, 145/147 bayam street and 2,4 and 6 and 2A,4A and 6A camden road london t/nos NGL543205 and NGL577454 and by way of first floating charge its undertaking and all its assets.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2004
    Consegnato il 10 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a les sans culottes at 27-29 endell street london WC2, and by way of assignment the goodwill of the business, the benefit of all the justices licence and any public entertainment;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 set 1992
    Consegnato il 21 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Worlds end public house (formerley k/a the mother redcap public house) 174 high street camden town t/n ngl 543205 and 1,3 & 5 greenland road 145/147 bayham street and 2, 4 & 6 and 2A, 4A & 6A camden road camden t/n ngl 577454 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge.
    Creato il 10 set 1992
    Consegnato il 17 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000 and all other moneys due or to become due from the company to allied breweries limited under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All that freehold property situate at and now known as the worlds end public house, 174 high street , cambden town, london NW1, title no ngl 543205 and the freehold property known as and being situate at and known as 1,3 and 5 greenland road, 145 and 147 bayham road, camden town , london NW1,title no ngl 577454 .
    Persone aventi diritto
    • Allied Breweries Limited.
    Transazioni
    • 17 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1991
    Consegnato il 07 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H, the pig and whistle ironbridge uxbridge road southall middlesex WB1 3EG and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 lug 1987
    Consegnato il 20 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 ago 1975
    Consegnato il 21 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. & book debts by fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0