KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED

KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01076715
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Units 2 & 3 Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Kent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FREEMAN CONTRACTS LIMITED15 mag 199015 mag 1990
    FREEMAN INSULATION LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    MODERN PLAN INSULATION (SOUTH EAST) LIMITED16 ott 197216 ott 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al04 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2024

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Ashley Robinson come amministratore in data 23 mag 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2023

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2022

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Ashley Robinson come amministratore in data 28 apr 2022

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2021

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Anthony Hufton come amministratore in data 02 giu 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Elliot Jenkins come segretario in data 20 nov 2020

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2019

    11 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Sij Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 29 apr 2019

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian James Macklin il 29 apr 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Elliot Jenkins il 28 apr 2019

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Patricia Anne Macklin il 29 apr 2019

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2018 al 30 apr 2018

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Sij Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 30 apr 2018

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUFTON, Anthony
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    Amministratore
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector283835620001
    MACKLIN, Ian James
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    Amministratore
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector68901680001
    MACKLIN, Patricia Anne
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    Amministratore
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    EnglandBritishSecretary245873460001
    BONE, Raymond Peter Michael
    25 Common Road
    Witchford
    CB6 2HY Ely
    Cambridgeshire
    Segretario
    25 Common Road
    Witchford
    CB6 2HY Ely
    Cambridgeshire
    British9729600001
    JENKINS, Elliot
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    Segretario
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    245873640001
    SMITH, Kathleen Elizabeth
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Segretario
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    British100898190002
    BINGLEY, Giles William
    Pond House
    Thurlow Road, Great Bradley
    CB8 9LW Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Pond House
    Thurlow Road, Great Bradley
    CB8 9LW Newmarket
    Suffolk
    BritishAccountant66629480001
    BIRD, Edward Leonard
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    United KingdomBritishChairman68853550001
    BIRD, Edward Leonard
    5 Church Close
    Exning
    CB8 7EJ Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    5 Church Close
    Exning
    CB8 7EJ Newmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishEngineer68853550001
    BONE, Raymond Peter Michael
    25 Common Road
    Witchford
    CB6 2HY Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    25 Common Road
    Witchford
    CB6 2HY Ely
    Cambridgeshire
    BritishAccountant9729600001
    BRUNO, Frank
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishOperations Director194292220001
    CONSTABLE, Paul
    Highdown
    Sibleys Green
    CM6 2NU Thaxted
    Essex
    Amministratore
    Highdown
    Sibleys Green
    CM6 2NU Thaxted
    Essex
    BritishEngineer125629580001
    CROUCH, Andrew Colin Edward
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishFinance Director121710570002
    FINLAY, Mark Stephen
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishGroup Managing Director40312200001
    LLEWELLYN, David Guy
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    England
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    England
    EnglandEnglishNon-Executive Director118324350006
    MACKLIN, Ian James
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishOperations Director68901680001
    MCLEISH, Paul
    7 Westfield Way
    Langtoft
    PE6 9RH Peterborough
    Amministratore
    7 Westfield Way
    Langtoft
    PE6 9RH Peterborough
    EnglandBritishSales Director124749570001
    PYKE, Susan Ellen
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishDirector207361500001
    RAYSON, Michael George
    Fortesque Reads Street
    Stretham
    CB6 3JT Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Fortesque Reads Street
    Stretham
    CB6 3JT Ely
    Cambridgeshire
    BritishManaging Director38782500001
    ROBINSON, Ashley
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    Amministratore
    Lewis Industrial Estate
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector295246770001
    RUCK, Alexander
    Shenstones
    Thoroton
    NG13 9DS Nottingham
    Amministratore
    Shenstones
    Thoroton
    NG13 9DS Nottingham
    BritishBuilding Surveyor44258450001
    SAY, Jonathan David
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishSales And Business Development Director183532030001
    SMITH, Barry James
    Woodville Hatchill Hindhead Road
    Churt
    GU10 2NX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Woodville Hatchill Hindhead Road
    Churt
    GU10 2NX Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishSales Manager59066950001
    SPEED, Michael
    1a Primley Lane
    Sheering
    CM22 7NH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    1a Primley Lane
    Sheering
    CM22 7NH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishDirector39130220001
    SUMMERFIELD, Stephen
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Amministratore
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    EnglandBritishDirector128571860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sij Holdings Ltd
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3 Lewis Industrial Estate
    England
    30 apr 2018
    Wheatley Terrace Road
    DA8 2AP Erith
    Units 2 & 3 Lewis Industrial Estate
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione11156549
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    England
    22 mar 2018
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    England
    Forma giuridicaKershaw Services Limited
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2648024
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Mark Stephen Finlay
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    04 mag 2017
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    Mrs Julie Mary Finlay
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    04 mag 2017
    Pembroke Avenue
    Waterbeach
    CB25 9QR Cambridge
    Edward Leonard House
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment by way of security
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 06 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as determined in accordance with clause 6 of an agreement dated 16/1/92
    Brevi particolari
    By way of assignment all present and future rights title and interest of the company in:- a) all the agreements (see 395 for details) b) all sums payable c) all sums standing to the credit of the contract proceeds account (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Freeman Group PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 feb 1991
    Consegnato il 08 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 mar 1985
    Consegnato il 22 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1988Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 28 apr 1982
    Consegnato il 12 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 18 set 1981
    Consegnato il 29 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 19 gen 1981
    Consegnato il 03 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 1979
    Consegnato il 25 giu 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with all buildings & fixtures & fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 apr 1977
    Consegnato il 02 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. With all buildings, fixtures fixed plant & machinery fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1977Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 02 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0