KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01076715 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
- Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni
Dove si trova KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Units 2 & 3 Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Kent England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
FREEMAN CONTRACTS LIMITED | 15 mag 1990 | 15 mag 1990 |
FREEMAN INSULATION LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
MODERN PLAN INSULATION (SOUTH EAST) LIMITED | 16 ott 1972 | 16 ott 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2026 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 04 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 18 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 04 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2024 | 11 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Ashley Robinson come amministratore in data 23 mag 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2023 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2022 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Ashley Robinson come amministratore in data 28 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2021 | 10 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Anthony Hufton come amministratore in data 02 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Elliot Jenkins come segretario in data 20 nov 2020 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2020 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2019 | 11 pagine | AA | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2018 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Sij Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 29 apr 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian James Macklin il 29 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Elliot Jenkins il 28 apr 2019 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Patricia Anne Macklin il 29 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2018 al 30 apr 2018 | 1 pagine | AA01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 30 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Notifica di Sij Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 30 apr 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||
Chi sono gli amministratori di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUFTON, Anthony | Amministratore | Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Kent England | England | British | Director | 283835620001 | ||||
MACKLIN, Ian James | Amministratore | Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Kent England | England | British | Director | 68901680001 | ||||
MACKLIN, Patricia Anne | Amministratore | Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Kent England | England | British | Secretary | 245873460001 | ||||
BONE, Raymond Peter Michael | Segretario | 25 Common Road Witchford CB6 2HY Ely Cambridgeshire | British | 9729600001 | ||||||
JENKINS, Elliot | Segretario | Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Kent England | 245873640001 | |||||||
SMITH, Kathleen Elizabeth | Segretario | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | British | 100898190002 | ||||||
BINGLEY, Giles William | Amministratore | Pond House Thurlow Road, Great Bradley CB8 9LW Newmarket Suffolk | British | Accountant | 66629480001 | |||||
BIRD, Edward Leonard | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | United Kingdom | British | Chairman | 68853550001 | ||||
BIRD, Edward Leonard | Amministratore | 5 Church Close Exning CB8 7EJ Newmarket Suffolk | United Kingdom | British | Engineer | 68853550001 | ||||
BONE, Raymond Peter Michael | Amministratore | 25 Common Road Witchford CB6 2HY Ely Cambridgeshire | British | Accountant | 9729600001 | |||||
BRUNO, Frank | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Operations Director | 194292220001 | ||||
CONSTABLE, Paul | Amministratore | Highdown Sibleys Green CM6 2NU Thaxted Essex | British | Engineer | 125629580001 | |||||
CROUCH, Andrew Colin Edward | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Finance Director | 121710570002 | ||||
FINLAY, Mark Stephen | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Group Managing Director | 40312200001 | ||||
LLEWELLYN, David Guy | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House England | England | English | Non-Executive Director | 118324350006 | ||||
MACKLIN, Ian James | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Operations Director | 68901680001 | ||||
MCLEISH, Paul | Amministratore | 7 Westfield Way Langtoft PE6 9RH Peterborough | England | British | Sales Director | 124749570001 | ||||
PYKE, Susan Ellen | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Director | 207361500001 | ||||
RAYSON, Michael George | Amministratore | Fortesque Reads Street Stretham CB6 3JT Ely Cambridgeshire | British | Managing Director | 38782500001 | |||||
ROBINSON, Ashley | Amministratore | Lewis Industrial Estate Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Kent England | England | British | Director | 295246770001 | ||||
RUCK, Alexander | Amministratore | Shenstones Thoroton NG13 9DS Nottingham | British | Building Surveyor | 44258450001 | |||||
SAY, Jonathan David | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Sales And Business Development Director | 183532030001 | ||||
SMITH, Barry James | Amministratore | Woodville Hatchill Hindhead Road Churt GU10 2NX Farnham Surrey | United Kingdom | British | Sales Manager | 59066950001 | ||||
SPEED, Michael | Amministratore | 1a Primley Lane Sheering CM22 7NH Bishops Stortford Hertfordshire | British | Director | 39130220001 | |||||
SUMMERFIELD, Stephen | Amministratore | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | England | British | Director | 128571860001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij Holdings Ltd | 30 apr 2018 | Wheatley Terrace Road DA8 2AP Erith Units 2 & 3 Lewis Industrial Estate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Kershaw Services Limited | 22 mar 2018 | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mr Mark Stephen Finlay | 04 mag 2017 | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mrs Julie Mary Finlay | 04 mag 2017 | Pembroke Avenue Waterbeach CB25 9QR Cambridge Edward Leonard House | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
|
KERSHAW CONTRACTING SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Assignment by way of security | Creato il 03 feb 1992 Consegnato il 06 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as determined in accordance with clause 6 of an agreement dated 16/1/92 | |
Brevi particolari By way of assignment all present and future rights title and interest of the company in:- a) all the agreements (see 395 for details) b) all sums payable c) all sums standing to the credit of the contract proceeds account (see doc for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 feb 1991 Consegnato il 08 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 12 mar 1985 Consegnato il 22 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee & debenture | Creato il 28 apr 1982 Consegnato il 12 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee & debenture | Creato il 18 set 1981 Consegnato il 29 set 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee & debenture | Creato il 19 gen 1981 Consegnato il 03 feb 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 14 giu 1979 Consegnato il 25 giu 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with all buildings & fixtures & fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 apr 1977 Consegnato il 02 mag 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. With all buildings, fixtures fixed plant & machinery fixed & floating charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0