ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.

ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01077373
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    • fabbricazione di etichette stampate (18121) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Avebury House 201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLONDALKIN PHARMA & HEALTHCARE (KIMBOLTON) LTD.03 giu 201103 giu 2011
    DITONE LABELS LIMITED25 ago 198325 ago 1983
    DITONE PRODUCTS LIMITED19 ott 197219 ott 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 11 ott 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The premium share account cancelled 13/09/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Jon Michael Green come amministratore in data 15 lug 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Rayner come amministratore in data 30 apr 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Leonard Mcneil Kirk come amministratore in data 09 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Peter Rayner come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Iain Philip Percival come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hugh Alexander Ross come amministratore in data 14 feb 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 010773730008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010773730007 in pieno

    4 pagineMR04

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2015

    Stato del capitale al 28 ott 2015

    • Capitale: GBP 701
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Avebury House 225-229 Avebury Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1AU a Avebury House 225-229 Avebury Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1AU in data 20 ott 2015

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Jon Michael
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    Segretario
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    198453390001
    GREEN, Jon Michael
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish105507950005
    PERCIVAL, Iain Philip
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    EnglandBritish175638680001
    BERGIN, Liam Gerard
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Segretario
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Irish36702870001
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Segretario
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    British74242880001
    CARMICHAEL, James
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    British88088510001
    GUINEVAN, Alfred
    18 Adelaide Square
    MK40 2RW Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    18 Adelaide Square
    MK40 2RW Bedford
    Bedfordshire
    Irish39098360001
    KIRK, Leonard Mcneil
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House 201-249
    Buckinghamshire
    EnglandBritish299758440001
    LIGGINS, Craig Anthony
    c/o C\O Clondalkin \ Ap Burt
    Royal Portbury Dock
    Portbury
    BS20 7XP Bristol
    First Avenue
    England
    Amministratore
    c/o C\O Clondalkin \ Ap Burt
    Royal Portbury Dock
    Portbury
    BS20 7XP Bristol
    First Avenue
    England
    EnglandBritish80005310002
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Amministratore
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    EnglandBritish74242880001
    O'NEILL, Colman
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    IrelandIrish45448600001
    RAYNER, Peter Alexander
    Hall Park
    HP4 2NU Berkhamsted
    30
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hall Park
    HP4 2NU Berkhamsted
    30
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish187386230002
    ROSS, Hugh Alexander
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish246975310001
    STEVENSON, David Victor
    44 Spenser Road
    MK40 2BB Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    44 Spenser Road
    MK40 2BB Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish45909230002
    TANYAR, Feyzoullah Yalkin
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    British33720300001
    YOUNG, Raymond Samuel
    2 Stokemill Cottages Mill Road
    MK44 1NP Sharnbrook
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Stokemill Cottages Mill Road
    MK44 1NP Sharnbrook
    Bedfordshire
    United KingdomIrish49743820001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01935353
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 10 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 10 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 12 lug 2007
    Consegnato il 30 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 30 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 29 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all of the real property, by way of first fixed charge all estates or interests in any real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all of the charged deposits, all investments and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C. (The Security Agent) for Itself and on Behalf of the Securedcreditors
    Transazioni
    • 29 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second stage debenture
    Creato il 23 nov 1999
    Consegnato il 07 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to secured parties (or any of them) wheter collectively or individually under the finance doucments (or any of them) and under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1984
    Consegnato il 02 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H factory premises, little end road, eaton socon, cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1980
    Consegnato il 29 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 14B, little end road, eaton socon, st. Neots, cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 29 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ago 1975
    Consegnato il 15 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 15 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0