ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.
Panoramica
| Nome della società | ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD. |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01077373 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
- fabbricazione di etichette stampate (18121) / Industrie manifatturiere
Dove si trova ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Indirizzo della sede legale | Avebury House 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Buckinghamshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CLONDALKIN PHARMA & HEALTHCARE (KIMBOLTON) LTD. | 03 giu 2011 | 03 giu 2011 |
| DITONE LABELS LIMITED | 25 ago 1983 | 25 ago 1983 |
| DITONE PRODUCTS LIMITED | 19 ott 1972 | 19 ott 1972 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 11 ott 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Jon Michael Green come amministratore in data 15 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Rayner come amministratore in data 30 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Leonard Mcneil Kirk come amministratore in data 09 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Peter Rayner come amministratore in data 01 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Iain Philip Percival come amministratore in data 01 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Alexander Ross come amministratore in data 14 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 010773730008 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 010773730007 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Avebury House 225-229 Avebury Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1AU a Avebury House 225-229 Avebury Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1AU in data 20 ott 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, Jon Michael | Segretario | Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House 201-249 Buckinghamshire | 198453390001 | |||||||
| GREEN, Jon Michael | Amministratore | Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House 201-249 Buckinghamshire | United Kingdom | British | 105507950005 | |||||
| PERCIVAL, Iain Philip | Amministratore | 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House United Kingdom | England | British | 175638680001 | |||||
| BERGIN, Liam Gerard | Segretario | 17 Chesterfield View Castlenock IRISH Dublin 15 Ireland | Irish | 36702870001 | ||||||
| NICHOLLS, James Andrew | Segretario | 15 The Quays Cumberland Road BS1 6UQ Bristol | British | 74242880001 | ||||||
| CARMICHAEL, James | Amministratore | The Old Stable Yard Peveril Road LE17 5NQ Ashby Magna Leicestershire | British | 88088510001 | ||||||
| GUINEVAN, Alfred | Amministratore | 18 Adelaide Square MK40 2RW Bedford Bedfordshire | Irish | 39098360001 | ||||||
| KIRK, Leonard Mcneil | Amministratore | Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House 201-249 Buckinghamshire | England | British | 299758440001 | |||||
| LIGGINS, Craig Anthony | Amministratore | c/o C\O Clondalkin \ Ap Burt Royal Portbury Dock Portbury BS20 7XP Bristol First Avenue England | England | British | 80005310002 | |||||
| NICHOLLS, James Andrew | Amministratore | 15 The Quays Cumberland Road BS1 6UQ Bristol | England | British | 74242880001 | |||||
| O'NEILL, Colman | Amministratore | 110 Shrewsbury Lawn Cabinteely 18 Dublin Ireland | Ireland | Irish | 45448600001 | |||||
| RAYNER, Peter Alexander | Amministratore | Hall Park HP4 2NU Berkhamsted 30 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 187386230002 | |||||
| ROSS, Hugh Alexander | Amministratore | 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 246975310001 | |||||
| STEVENSON, David Victor | Amministratore | 44 Spenser Road MK40 2BB Bedford Bedfordshire | England | British | 45909230002 | |||||
| TANYAR, Feyzoullah Yalkin | Amministratore | Homewood House The Ridgeway EN6 4AX Cuffley Hertfordshire | British | 33720300001 | ||||||
| YOUNG, Raymond Samuel | Amministratore | 2 Stokemill Cottages Mill Road MK44 1NP Sharnbrook Bedfordshire | United Kingdom | Irish | 49743820001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD.?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esnt International Limited | 06 apr 2016 | 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ESSENTRA (KIMBOLTON) LTD. ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 31 mag 2013 Consegnato il 10 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 31 mag 2013 Consegnato il 10 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture | Creato il 12 lug 2007 Consegnato il 30 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 mar 2004 Consegnato il 29 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all of the real property, by way of first fixed charge all estates or interests in any real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all of the charged deposits, all investments and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second stage debenture | Creato il 23 nov 1999 Consegnato il 07 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to secured parties (or any of them) wheter collectively or individually under the finance doucments (or any of them) and under the deed | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 set 1984 Consegnato il 02 ott 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H factory premises, little end road, eaton socon, cambridgeshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 feb 1980 Consegnato il 29 feb 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H unit 14B, little end road, eaton socon, st. Neots, cambridgeshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 ago 1975 Consegnato il 15 ago 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery fixed & floating charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0