REDSKY IT (593) LIMITED

REDSKY IT (593) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDSKY IT (593) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01082593
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REDSKY IT (593) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova REDSKY IT (593) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Colmore Row
    Birmingham
    B3 2AS West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REDSKY IT (593) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAMESYS (AEC) LIMITED06 giu 200006 giu 2000
    SYNTECH (UK) LIMITED06 feb 199706 feb 1997
    SYNTECH COMPUTER SYSTEMS LIMITED02 giu 198702 giu 1987
    SOKENWICK LIMITED20 nov 197220 nov 1972

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDSKY IT (593) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2007

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REDSKY IT (593) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REDSKY IT (593) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ago 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ago 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ago 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ago 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ago 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 feb 2009

    5 pagine4.68

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2007

    5 pagineAA

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cash dividend appr 21/02/2008
    RES13

    legacy

    6 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return06 ago 2007

    legacy

    363(353)

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di REDSKY IT (593) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Segretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    MCFARLANE, James Douglas
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    Amministratore
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    CanadaCanadian118810110001
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Segretario
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Segretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    ELMS, Leighton William
    42 Porset Drive
    CF8 1PP Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Segretario
    42 Porset Drive
    CF8 1PP Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British13309540001
    BARNHOUSE, Terence
    2 St Medard Road
    BS28 4AY Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    2 St Medard Road
    BS28 4AY Wedmore
    Somerset
    British48228710001
    BASHFORD, Howard
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    British68140690003
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Amministratore
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    BRIDDON, Kenneth Carl
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    British76868400001
    CHAMBERS, Mark
    428 Goldington Road
    MK41 9NU Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    428 Goldington Road
    MK41 9NU Bedford
    Bedfordshire
    British78433770004
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    EARLEY, Martin John Raymond
    36 Briarmeadow Drive
    Thornhill
    CF4 9FB Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    36 Briarmeadow Drive
    Thornhill
    CF4 9FB Cardiff
    South Glamorgan
    British19312960001
    FULLER, Andrew Jonathan
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    Amministratore
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    British132077340001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HOTSON, Crispian John
    1b King Street
    SW1Y 6QG London
    Amministratore
    1b King Street
    SW1Y 6QG London
    British97996100001
    JONES, Warren
    8 Bishops Close
    Whitchurch
    CF4 1NH Cardiff
    Amministratore
    8 Bishops Close
    Whitchurch
    CF4 1NH Cardiff
    British59711890002
    LOCKYER, Stephen Charles
    13 Summerwood Close
    CF5 3QS Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    13 Summerwood Close
    CF5 3QS Cardiff
    South Glamorgan
    British67414890001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Amministratore
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    MCPHERSON, Ian
    Whitebrook
    NP6 3BA Llanvaches
    Chepstow
    Amministratore
    Whitebrook
    NP6 3BA Llanvaches
    Chepstow
    British47733900001
    MORGAN, Patrick Francis
    4 Church Bank
    Whaley Lane Whaley Bridge High Peak
    SK23 7RZ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    4 Church Bank
    Whaley Lane Whaley Bridge High Peak
    SK23 7RZ Stockport
    Cheshire
    British37486070003
    NORFORD, Craig
    167 Paddick Drive
    Earley
    RG6 4HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    167 Paddick Drive
    Earley
    RG6 4HG Reading
    Berkshire
    British78433720002
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    PEEK, David Richard
    Nant Y Deri Began Road
    Michaelston Y Fedw
    CF3 6XL Cardiff
    Amministratore
    Nant Y Deri Began Road
    Michaelston Y Fedw
    CF3 6XL Cardiff
    British32453010001
    ROGERS, Christine Margaret
    Ty Cudyll
    Pen Y Waun, Pentyrch
    CF15 9SJ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Ty Cudyll
    Pen Y Waun, Pentyrch
    CF15 9SJ Cardiff
    South Glamorgan
    British66374680001
    SMITH, David Anthony Bradford
    7 Langland Villas
    Mumbles
    SA3 4NA Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    7 Langland Villas
    Mumbles
    SA3 4NA Swansea
    West Glamorgan
    British13309590001
    SMITH, Dennis George, Dr
    10 St Quentins Close
    Llanblethian
    CF7 7EZ Cowbridge
    South Glamorgan
    Amministratore
    10 St Quentins Close
    Llanblethian
    CF7 7EZ Cowbridge
    South Glamorgan
    British37732060001
    SPRING, Simon Christopher
    1 Chestnut Close
    Middle Assendon
    RG9 6AY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 Chestnut Close
    Middle Assendon
    RG9 6AY Henley On Thames
    Oxfordshire
    British2039620001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    THOMAS, Clive Jeremy
    1 Hawkridge Cottage
    Hawkridge Hill
    RG18 9XA Frilsham Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Hawkridge Cottage
    Hawkridge Hill
    RG18 9XA Frilsham Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish157829380001
    TOSH, Stephen Leonard
    3 Doddington Place
    Trallwn
    CF37 4LN Pontypridd
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    3 Doddington Place
    Trallwn
    CF37 4LN Pontypridd
    Mid Glamorgan
    British74102060001
    WEIR, Robert James
    35 Blackhorse Lane
    SG4 9EG Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    35 Blackhorse Lane
    SG4 9EG Hitchin
    Hertfordshire
    British59711990001

    REDSKY IT (593) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 gen 1999
    Consegnato il 04 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee acting as security trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the senior finance documents (as therein defined) and all monies due or owing to each beneficiary by each other company (except as a guarantor for the chargor giving this covenant) under or pursuant to the senior finance documents and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 04 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 17 gen 1994
    Consegnato il 26 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from palm technology PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 dic 1991
    Consegnato il 24 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter of even date not exceeding £150,000
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Ryan International Limited
    Transazioni
    • 24 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 1991
    Consegnato il 24 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 dic 1989
    Consegnato il 05 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 24 giu 1980
    Consegnato il 01 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property, undertaking & assets charged by the principal deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    REDSKY IT (593) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 feb 2008Inizio della liquidazione
    16 ago 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0