MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED
Panoramica
Nome della società | MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01087316 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
- Istruzione secondaria generale (85310) / Istruzione
Dove si trova MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 26 Whitehall Road LS12 1BE Leeds |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
YORKSHIRE POST TRAINING LIMITED | 25 ago 1989 | 25 ago 1989 |
YORKSHIRE POST ELECTRONICS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 28 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 mag 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Gilroy Mark Highfield il 01 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David John King il 01 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Mccall il 01 lug 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David John King come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Grant Murray come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Cammiade come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* in data 06 dic 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Fry come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Grant Murray come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCALL, Peter | Segretario | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 147015850001 | |||||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
KING, David John | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
COOPER, Philip Richard | Segretario | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | 131295290001 | ||||||
HILL, Robert Christopher | Segretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | Company Secretary | 72684940002 | |||||
MILNES, Ann | Segretario | 5 Dawsons Meadow Farsley LS28 5TU Pudsey West Yorkshire | British | Company Secretary | 59652640002 | |||||
YEOMANS, Graham Arthur | Segretario | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
ARMITAGE, Kathryn | Amministratore | 6 Coniston Close Penistone S36 8HQ Sheffield South Yorkshire | England | British | Finance Director | 93906390001 | ||||
ATKINSON, Peter Graham | Amministratore | 22 Usher Park Road Haxby YO32 3RY York North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 70358530001 | ||||
AUCKLAND, Stephen Andrew | Amministratore | The Croft 12 Town End Lane HD8 0NA Lepton Huddersfield | British | Company Director | 81185280001 | |||||
BOWDLER, Timothy John | Amministratore | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | Company Director | 37521870002 | ||||
CAMMIADE, Danny | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | Chief Operating Officer | 251394160001 | ||||
CLARKE, Austin | Amministratore | Old Parsonage House Parsons Road BD9 4DW Bradford West Yorkshire | British | Director | 53792790002 | |||||
CROSSMAN, Janet Lesley | Amministratore | 27 High Meadows Walton WF2 6TN Wakefield West Yorkshire | England | British | Director | 103578240001 | ||||
FRY, John Anthony | Amministratore | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | Chief Executive | 136914890001 | ||||
HOLBROCK, Gerald Lawrence | Amministratore | Bridge End Cottage Stammergate Lane Linton LS22 4JB Wetherby West Yorkshire | British | Director | 44240180001 | |||||
LAVERICK, Susan Christine | Amministratore | Sycamore Cottage Park Lane, Emley HD8 9SS Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 99591930001 | ||||
MURRAY, Grant | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
OAKLEY, Christopher John | Amministratore | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | Director | 68410390001 | |||||
PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 64281400001 | ||||
WRIGHT, David Edmondson | Amministratore | The Stables Highfield Park Creaton NN6 8NT Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 141763690001 |
MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture | Creato il 04 mar 1999 Consegnato il 17 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by the obligors(as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 feb 1998 Consegnato il 11 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0