MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED

MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01087316
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
    • Istruzione secondaria generale (85310) / Istruzione

    Dove si trova MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26 Whitehall Road
    LS12 1BE Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YORKSHIRE POST TRAINING LIMITED 25 ago 198925 ago 1989
    YORKSHIRE POST ELECTRONICS LIMITED31 dic 198131 dic 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 mag 2015

    • Capitale: GBP 5
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Gilroy Mark Highfield il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John King il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Mccall il 01 lug 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2014

    Stato del capitale al 12 mag 2014

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2012

    8 pagineAA

    Nomina di Mr David John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Grant Murray come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Cammiade come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* in data 06 dic 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Fry come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Grant Murray come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Segretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    147015850001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Segretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary72684940002
    MILNES, Ann
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary59652640002
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Segretario
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    ARMITAGE, Kathryn
    6 Coniston Close
    Penistone
    S36 8HQ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    6 Coniston Close
    Penistone
    S36 8HQ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director93906390001
    ATKINSON, Peter Graham
    22 Usher Park Road
    Haxby
    YO32 3RY York
    North Yorkshire
    Amministratore
    22 Usher Park Road
    Haxby
    YO32 3RY York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector70358530001
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    Amministratore
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    BritishCompany Director81185280001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Amministratore
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritishChief Operating Officer251394160001
    CLARKE, Austin
    Old Parsonage House Parsons Road
    BD9 4DW Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Parsonage House Parsons Road
    BD9 4DW Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector53792790002
    CROSSMAN, Janet Lesley
    27 High Meadows
    Walton
    WF2 6TN Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    27 High Meadows
    Walton
    WF2 6TN Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector103578240001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Amministratore
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishChief Executive136914890001
    HOLBROCK, Gerald Lawrence
    Bridge End Cottage Stammergate Lane
    Linton
    LS22 4JB Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bridge End Cottage Stammergate Lane
    Linton
    LS22 4JB Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector44240180001
    LAVERICK, Susan Christine
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector99591930001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    OAKLEY, Christopher John
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector68410390001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    WRIGHT, David Edmondson
    The Stables Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Stables Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector141763690001

    MOTOR MARKET WEEKLY (CALEDONIAN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 17 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors(as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC Capital Markets(As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 17 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 11 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0