BROUGHTON CONTROLS LIMITED
Panoramica
Nome della società | BROUGHTON CONTROLS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01089363 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Apex Building 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
STEVMORE LIMITED | 02 gen 1973 | 02 gen 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Hamer Broughton come amministratore in data 17 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA England a Apex Building 1 Water Vole Way Doncaster DN4 5JP in data 21 giu 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Crh Fencing & Security Group (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 07 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Wightman come amministratore in data 26 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Cameron David William Burnett come amministratore in data 25 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 33 Stakehill Industrial Estate Middleton Manchester M24 2RW a Carr Hill Herons Way Balby Doncaster DN4 8WA in data 27 feb 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Cameron David William Burnett come amministratore in data 04 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kenneth Peach come amministratore in data 15 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kenneth Peach come segretario in data 15 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kenneth Peach come segretario in data 15 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABOT, Gilles | Amministratore | 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster Apex Building England | Netherlands | French | Director | 201716350001 | ||||
BROUGHTON, Dorothy Anne | Segretario | Tame Vale House Range Lane OL3 5SA Denshaw, Oldham Lancashire | English | 14265450002 | ||||||
CHADWICK, Philip | Segretario | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | British | Chartered Accountant | 66886670002 | |||||
DINSLEY, George Paul | Segretario | The Beeches 170 Dickens Lane Poynton SK12 1NU Stockport Cheshire | British | Accountant | 45881950002 | |||||
PEACH, Andrew Kenneth | Segretario | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 | 218998790001 | |||||||
BROUGHTON, Dorothy Anne | Amministratore | Tame Vale House Range Lane OL3 5SA Denshaw, Oldham Lancashire | English | Company Secretary | 14265450002 | |||||
BROUGHTON, Eric | Amministratore | Tamevale House Range Lane Denshaw OL3 5SA Oldham Lancashire | English | Managing Director | 12263850002 | |||||
BROUGHTON, Jonathan Hamer | Amministratore | 1 Water Vole Way DN4 5JP Doncaster Apex Building England | United Kingdom | British | Company Director | 109768740001 | ||||
BURNETT, Cameron David William | Amministratore | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Carr Hill South Yorkshire England | England | British | Country Manager Uk | 190998110001 | ||||
CHADWICK, Philip | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | England | British | Financial Director | 66886670002 | ||||
DICKMAN, Barry Scot | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Sales Director | 75250520001 | ||||
GOODE, Laurence Piers | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Managing Director | 66109460001 | ||||
KELLY, Roger Grant | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | United Kingdom | British | Company Director | 67569120001 | ||||
KEYWORTH, Stanley John | Amministratore | 18 Landsdowne Crescent WR14 2AW Malvern Worcestershire | England | British | Director | 75121880002 | ||||
PEACH, Andrew Kenneth | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 | United Kingdom | British | Managing Director | 42769440002 | ||||
THOMAS, Philip Kenyon | Amministratore | The Rydings 4 Hill Grove HD3 3TL Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 14692390001 | |||||
TOWERS, Simon Andrew | Amministratore | Stakehill Industrial Estate Middleton M24 2RW Manchester 33 England | England | British | Company Director | 41657420002 | ||||
VALLELY, Anthony William | Amministratore | Hulme Hall Avenue SK8 6LN Cheadle Hulme 30 Cheshire | England | British | Financial Director | 138990030001 | ||||
VAN SCHIJNDEL, Gerardus Johannes Cornelius Theresia | Amministratore | Delmerweg 33 5037 Gj Tilburg Netherlands | Netherlands | Dutch | Director | 85810500001 | ||||
WIGHTMAN, Michael | Amministratore | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Carr Hill England | Northern Ireland | British | Director | 144988980001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BROUGHTON CONTROLS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heras Perimeter Protection Limited | 06 apr 2016 | Herons Way Balby DN4 8WA Doncaster Herons Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BROUGHTON CONTROLS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 17 ago 1999 Consegnato il 26 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 ago 1999 Consegnato il 26 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the east side of shaw road oldham t/n's GM538197, LA296148, OL7661 and GM200732. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 nov 1987 Consegnato il 19 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H / l/h property k/a or being land and buildings on shaw road oldham greater manchester title no:- la 296148 ol 7661 gm 200732 with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0