STEPHEN JAMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STEPHEN JAMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01089649 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STEPHEN JAMES LIMITED?
- Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova STEPHEN JAMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 1 Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STEPHEN JAMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DUNCAN COLLINS (FINCHLEY) LIMITED | 03 gen 1973 | 03 gen 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STEPHEN JAMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per STEPHEN JAMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 07 giu 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Susan Charlotte Collins come amministratore in data 20 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Duncan Paul Collins come amministratore in data 20 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Steve Breese il 23 ago 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 36 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Steve Breese come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di STEPHEN JAMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREESE, Steve | Segretario | Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield Unit 1 | 165225660001 | |||||||
| BREESE, Steve | Amministratore | Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield Unit 1 | United Kingdom | British | 159332220001 | |||||
| COLLINS, Benjamin James | Amministratore | Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield Unit 1 | United Kingdom | British | 77074140003 | |||||
| CAMP, Lee Michael Richard | Segretario | Jordan Court Flawn Way PE19 2JN St Neots Flat 12 Cambridgeshire | British | 146725440001 | ||||||
| COLLINS, Duncan Paul | Segretario | 37 Eversley Crescent Winchmore Hill N21 1EL London | British | 2925690002 | ||||||
| ADAMS, John Sidney | Amministratore | Meadow View 1 Parkland Drive AL3 4AH St Albans Hertfordshire | British | 26079100001 | ||||||
| CAMP, Lee Michael Richard | Amministratore | Jordan Court Flawn Way PE19 2JN St Neots Flat 12 Cambridgeshire | Gbr | British | 146725440001 | |||||
| COLLINS, Duncan Paul | Amministratore | Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield Unit 1 | United Kingdom | British | 2925690002 | |||||
| COLLINS, Susan Charlotte | Amministratore | Martinbridge Estate Lincoln Road EN1 1SP Enfield Unit 1 | United Kingdom | British | 35976470002 | |||||
| JONES, Philip David | Amministratore | 29 Northaw Road East EN6 4LU Cuffley Hertfordshire | British | 2925670002 | ||||||
| NATHAN, William | Amministratore | 20 Maidstone Road N11 2TP London | British | 4885130001 | ||||||
| ROPER, Trevor | Amministratore | 12 Plough Hill Cuffley EN6 4DR Potters Bar Hertfordshire | British | 46023820002 | ||||||
| SMITH, Michael Rennie | Amministratore | 4 Montpelier Road CR8 2QA Purley Surrey | British | 68494440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di STEPHEN JAMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dc Management Services Limited | 06 apr 2016 | Lincoln Road EN1 1SP Enfield 1 Martinbridge Estate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
STEPHEN JAMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 21 ago 2003 Consegnato il 23 ago 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Garage premises at clock parade, enfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 ago 2003 Consegnato il 23 ago 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 5/6 clock parade, enfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 ago 2003 Consegnato il 23 ago 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 dic 2000 Consegnato il 23 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold property k/a 5 & 6 clock parade london road enfield middx EN2 6JG. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 02 mar 1994 Consegnato il 10 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 ago 1988 Consegnato il 12 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Garage premises in clock parade, london road, enfield l/b of enfield. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 dic 1987 Consegnato il 07 gen 1988 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All those monies from time to time owing to the co. By bmw (GB) LTD. In respect of refunds of monies paid by or by the direction of the co. To bmw (GB) LTD. By way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. (See form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 ott 1987 Consegnato il 27 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Garage, showroom and workshop at 70/76 london road (even numbers only) enfield, l/b of enfield. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 set 1985 Consegnato il 13 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 feb 1985 Consegnato il 11 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies owing by bmw (GB) limited to the company in respect of refunds of monies paid by the direction of the company to bmw (GB) limited. See doc for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 30 mar 1983 Consegnato il 15 apr 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or stephen james limited to the chargee on any accountant whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0