STEPHEN JAMES LIMITED

STEPHEN JAMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTEPHEN JAMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01089649
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STEPHEN JAMES LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova STEPHEN JAMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STEPHEN JAMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNCAN COLLINS (FINCHLEY) LIMITED03 gen 197303 gen 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di STEPHEN JAMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STEPHEN JAMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 giu 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Susan Charlotte Collins come amministratore in data 20 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Duncan Paul Collins come amministratore in data 20 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2015

    Stato del capitale al 26 ott 2015

    • Capitale: GBP 1,012,075
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2014

    Stato del capitale al 29 set 2014

    • Capitale: GBP 1,012,075
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2014

    Stato del capitale al 03 set 2014

    • Capitale: GBP 1,012,075
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steve Breese il 23 ago 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    36 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2013

    Stato del capitale al 03 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,012,075
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Steve Breese come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di STEPHEN JAMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREESE, Steve
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    Segretario
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    165225660001
    BREESE, Steve
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    Amministratore
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    United KingdomBritish159332220001
    COLLINS, Benjamin James
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    Amministratore
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    United KingdomBritish77074140003
    CAMP, Lee Michael Richard
    Jordan Court
    Flawn Way
    PE19 2JN St Neots
    Flat 12
    Cambridgeshire
    Segretario
    Jordan Court
    Flawn Way
    PE19 2JN St Neots
    Flat 12
    Cambridgeshire
    British146725440001
    COLLINS, Duncan Paul
    37 Eversley Crescent
    Winchmore Hill
    N21 1EL London
    Segretario
    37 Eversley Crescent
    Winchmore Hill
    N21 1EL London
    British2925690002
    ADAMS, John Sidney
    Meadow View 1 Parkland Drive
    AL3 4AH St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadow View 1 Parkland Drive
    AL3 4AH St Albans
    Hertfordshire
    British26079100001
    CAMP, Lee Michael Richard
    Jordan Court
    Flawn Way
    PE19 2JN St Neots
    Flat 12
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Jordan Court
    Flawn Way
    PE19 2JN St Neots
    Flat 12
    Cambridgeshire
    GbrBritish146725440001
    COLLINS, Duncan Paul
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    Amministratore
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    United KingdomBritish2925690002
    COLLINS, Susan Charlotte
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    Amministratore
    Martinbridge Estate
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    Unit 1
    United KingdomBritish35976470002
    JONES, Philip David
    29 Northaw Road East
    EN6 4LU Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Northaw Road East
    EN6 4LU Cuffley
    Hertfordshire
    British2925670002
    NATHAN, William
    20 Maidstone Road
    N11 2TP London
    Amministratore
    20 Maidstone Road
    N11 2TP London
    British4885130001
    ROPER, Trevor
    12 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DR Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DR Potters Bar
    Hertfordshire
    British46023820002
    SMITH, Michael Rennie
    4 Montpelier Road
    CR8 2QA Purley
    Surrey
    Amministratore
    4 Montpelier Road
    CR8 2QA Purley
    Surrey
    British68494440001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STEPHEN JAMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dc Management Services Limited
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    1 Martinbridge Estate
    England
    06 apr 2016
    Lincoln Road
    EN1 1SP Enfield
    1 Martinbridge Estate
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02052212
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    STEPHEN JAMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 ago 2003
    Consegnato il 23 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage premises at clock parade, enfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 2003
    Consegnato il 23 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5/6 clock parade, enfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2003
    Consegnato il 23 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2000
    Consegnato il 23 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a 5 & 6 clock parade london road enfield middx EN2 6JG.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 02 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1988
    Consegnato il 12 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage premises in clock parade, london road, enfield l/b of enfield.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 dic 1987
    Consegnato il 07 gen 1988
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All those monies from time to time owing to the co. By bmw (GB) LTD. In respect of refunds of monies paid by or by the direction of the co. To bmw (GB) LTD. By way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • B M W Fianance (GB) Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1987
    Consegnato il 27 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage, showroom and workshop at 70/76 london road (even numbers only) enfield, l/b of enfield.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 set 1985
    Consegnato il 13 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 1985
    Consegnato il 11 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies owing by bmw (GB) limited to the company in respect of refunds of monies paid by the direction of the company to bmw (GB) limited. See doc for further details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 mar 1983
    Consegnato il 15 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or stephen james limited to the chargee on any accountant whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0