HGR GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | HGR GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01092449 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HGR GROUP LIMITED?
- Attività di organizzazioni ed enti extraterritoriali (99000) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HGR GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Priory House Priory Road DY1 1HH Dudley West Midlands England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HGR GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HARROD & GALL LIMITED | 25 gen 1973 | 25 gen 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HGR GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per HGR GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Alpha House 42 New Road Stourbridge West Midlands DY8 1PA England a 2 Priory House Priory Road Dudley DY1 1HH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 2 Priory House Priory Road Dudley West Midlands DY1 1HH | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ian Donald Morgan come amministratore in data 23 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Barry Francis Webley come amministratore in data 23 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Richard Rogers come amministratore in data 29 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Richard Rogers come segretario in data 29 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr John Barry Francis Webley come amministratore in data 29 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Edward Price come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Alpha House 42 New Road Stourbridge West Midlands DY8 1PA a 2 Priory House Priory Road Dudley West Midlands DY1 1HH in data 13 mag 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jane Walker come amministratore in data 03 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 |
Chi sono gli amministratori di HGR GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGAN, Ian Donald | Amministratore | Priory House Priory Road DY1 1HH Dudley 2 West Midlands England | England | English | Accountant | 244248790001 | ||||
HARROD, Charles Peter Lawley | Segretario | Crowfields Farm Fockbury Road Dodford B61 9AW Bromsgrove Worcestershire | British | 8974460002 | ||||||
ROGERS, Michael Richard | Segretario | 8 The Highfields Wightwick WV6 8HU Wolverhampton West Midlands | British | 22592270002 | ||||||
GALL, Bryan James | Amministratore | Willows Brook 8 Newfield Road Hagley DY9 0JP Stourbridge West Midlands | Great Britain | British | Insurance Broker | 8974470001 | ||||
HARROD, Charles Peter Lawley | Amministratore | Crowfields Farm Fockbury Road Dodford B61 9AW Bromsgrove Worcestershire | British | Insurance Broker | 8974460002 | |||||
PRICE, David Edward | Amministratore | 28-30 Wolverhampton Street DY1 1DB Dudley Finch House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 27434470002 | ||||
ROGERS, Jean | Amministratore | 31 Sandyfields Road Sedgley DY3 3LB Dudley West Midlands | Great Britain | British | Insurance Broker | 8974480001 | ||||
ROGERS, Michael Richard | Amministratore | 8 The Highfields Wightwick WV6 8HU Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Solicitor | 22592270002 | ||||
TANNER, Martyn Wayne | Amministratore | Oakwood 5 Plantation Lane Himley DY3 4LL Dudley West Midlands | Great Britain | British | Financial Adviser | 8974510002 | ||||
WALKER, Jane | Amministratore | Alpha House 42 New Road DY8 1PA Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Director | 180485120001 | ||||
WEBLEY, John Barry Francis | Amministratore | Priory House Priory Road DY1 1HH Dudley 2 West Midlands England | England | British | Retired | 23690930001 | ||||
WEBLEY, John Barry Francis | Amministratore | 9 Spring Close Kinver DY7 6BE Stourbridge West Midlands | England | British | Insurance Broker | 23690930001 | ||||
WILLIAMSON, Katrina | Amministratore | Alpha House 42 New Road DY8 1PA Stourbridge West Midlands | England | British | Financial Advisor | 173698000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HGR GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Michael Richard Rogers | 10 feb 2017 | Priory House Priory Road DY1 1HH Dudley 2 West Midlands England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
HGR GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 15 ott 2004 Consegnato il 16 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 42 new road stourbridge west midlands,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Confirmatory charge supplemental to a mortgage debenture dated 13 november 1991 made between the company and national westminster bank PLC | Creato il 04 nov 1996 Consegnato il 07 nov 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture dated 13 november 1991. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Confirmatory charge supplemental to a legal mortgage dated 16 january 1991 made between the company and national westminster bank PLC | Creato il 04 nov 1996 Consegnato il 07 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold property k/a 6 bath road stourbridge stourport west midlands t/n WM89191 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Confirmatory charge supplemental to a legal mortgage dated 20 january 1989 made between the company and national westminster bank PLC | Creato il 04 nov 1996 Consegnato il 07 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold property k/a 4 bath road stourbridge stourport west midlands t/n WM140098 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 13 nov 1991 Consegnato il 22 nov 1991 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 16 gen 1991 Consegnato il 18 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 6, bath road, stourbridge west midlands. T/n wm 89191 the proceeds of sale together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 20 gen 1989 Consegnato il 26 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 4 bath road stourbridge west midlands t/n wm 140098 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered pursuant to an order of court dated 12/1/88 | Creato il 16 mag 1987 Consegnato il 22 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing £20,000 and further advances due from the company to alliance and leicester building society including all moneys due under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/Hold property k/as 56 northfield rd netherton dudley, west midlands t/n wm 308158. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0