CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED

CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01093474
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J S REALIZATION NUMBER NINE LIMITED18 mag 198918 mag 1989
    SWINTON PROPERTIES LIMITED06 giu 198606 giu 1986
    MYNSHUL HOLDINGS LIMITED31 gen 197331 gen 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Allister Paul Turner come amministratore in data 27 feb 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Charles Plumer come amministratore in data 27 feb 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Annabel Felicity Wilson come segretario in data 27 feb 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christian Charles Plumer come segretario in data 27 feb 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Gilles Normand come amministratore in data 17 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christophe Marie Fred Bardet come amministratore in data 17 gen 2015

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Georges Desray come segretario in data 08 lug 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Christian Charles Plumer come amministratore in data 08 lug 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Christian Charles Plumer come segretario in data 08 lug 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Georges Desray come amministratore in data 08 lug 2014

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Stato del capitale al 21 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Sum of £299,999 credited to p/l acc & re sect 28 deletion of mems 26/06/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Georges Desray il 28 ago 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Georges Desray come amministratore in data 01 gen 2012

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Annabel Felicity
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    196039140001
    NORMAND, Gilles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchDirector175288680001
    TURNER, Allister Paul
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector86414540001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    169864970001
    HARGREAVES, Sally Anne
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Segretario
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    English1778900007
    HARGREAVES, Sally Anne
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    English1778900007
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    189559460001
    YOUNG, Bernadette Clare
    21 Kent View Avenue
    SS9 1HE Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    21 Kent View Avenue
    SS9 1HE Leigh On Sea
    Essex
    British52675260002
    BARDET, Christophe Marie Fred
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchChief Executive165770320001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector132720300001
    CLARE, Anthony Peter
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector51441260002
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandFrenchDirector167333040002
    GODDARD, Anthony William
    83 Vancouver Quay
    M5 2TX Salford
    Lancashire
    Amministratore
    83 Vancouver Quay
    M5 2TX Salford
    Lancashire
    BritishSurveyor2489550001
    HALPIN, Peter Joseph
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Amministratore
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    United KingdomBritishDirector38789050002
    HARGREAVES, Sally Anne
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    27 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DG Altrincham
    Cheshire
    United KingdomEnglishLegal Manager1778900007
    JONES, Glyn Elfed
    15 Cottage Lawns
    Hayes Lane
    SK9 7NF Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    15 Cottage Lawns
    Hayes Lane
    SK9 7NF Alderley Edge
    Cheshire
    BritishCompany Director48028270002
    NEEDHAM, Karen
    The Old Vicarage
    Winster
    LA23 3NU Windermere
    Cumbria
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Winster
    LA23 3NU Windermere
    Cumbria
    BritishSolicitor30017980001
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector130813500001
    SCOWCROFT, Brian Kenneth
    155 The Green
    Worsley
    M28 2PA Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    155 The Green
    Worsley
    M28 2PA Manchester
    Lancashire
    BritishChartered Accountant1778920001
    SCOWCROFT, Janet
    Ladyhill Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    Amministratore
    Ladyhill Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    BritishSolicitor3783100001
    SCOWCROFT, Joyce
    7 Greenside
    Worsley
    M28 2GR Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    7 Greenside
    Worsley
    M28 2GR Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director20213950001
    SCOWCROFT, Kenneth, Exors Of
    Rosthwaite Farm Storrs Park
    Ghyll Head, Bowness On Windermere
    LA23 3LX Windermere
    Cumbria
    Amministratore
    Rosthwaite Farm Storrs Park
    Ghyll Head, Bowness On Windermere
    LA23 3LX Windermere
    Cumbria
    EnglandBritishInsurance Broker74407030001
    SMITH, Patrick Joseph Edward
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Amministratore
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    EnglandBritishInsurer157973240001
    NON-DESTRUCTIVE TESTERS LIMITED
    St Mark's Court
    Chart Way
    RH12 1XL Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    St Mark's Court
    Chart Way
    RH12 1XL Horsham
    West Sussex
    44011160002

    CALL I FOR INSURANCE SERVICES ON 0800 1235789 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1986
    Consegnato il 07 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot 8 porth of paln estate llangelni gwynedd fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bajnk of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1986
    Consegnato il 07 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land together with the buildings erected thereon known as 2 pall mall chorley lancashire fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 07 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 30/12/83 relating to f/h land on the north east of buxton road stockport greater manchester & f/h land with property 431 buxton road stockport title nos ch 40129 & ch 52237.
    Persone aventi diritto
    • Williams and Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 30/12/83 relating to f/h 31 & 33 oxton road birkenhead wirral greater manchester title no ms 48537.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 30/12/84 relating to f/h land on the south side of chapel street now known as stamford house salford greater manchester title no la 32261.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of an agreement dated 30/12/83 relating to f/h 10 stockport road denton tameside greater manchester title no gm 49807.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Benefit of an agreement dated 30/12/83 relating to l/h 44 station road cheadle hulme stockport greater manchester title no gm 45601.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 19 gen 1983
    Consegnato il 07 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property ebing woodland and pasture field schedule at carnel fell in the county of cumbria and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 08 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as rosthwaite farm, windermere cumbria, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    116 union street, oldham title no. Ol 3697 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    94 bury old road, crumpsall greater manchester title no. La 151659 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 8 efordd gwenllian brosyr john llanfaitpuill in the county of anglesey and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    91 chorley road, swinton greater manchester title no la 3188222 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 59 washway road, sale greater manchester, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    203 chorley road, swinton & pendlebury, greater manchester title no. La 158988 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south east side of oldham road, manchester title nos. La 332242 & la 332243 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as "ambawela" upper storrs park road, bowness on windermere, cumria, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as plots of land situate at birks road park cliffe farm, windermere cumbria, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as plot of land situate on the storrs estate, windermere cumbria, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    100 liverpool road, south maghull, merseyside title no. Ms 109913 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    80O stockport road, levenshulme, greater manchester title no. Gm 198655 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 and 33 princess street manchester, greater manchester title no gm 103081 and/theyor the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    137 high street, little lever greater manchester title no. Gm 186309 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 30 set 1982
    Consegnato il 05 ott 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north west side cromwell road, salford, greater manchester. Title no. La 243293 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1981
    Consegnato il 12 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All those freehold parcels of land with the farmhouse & buildings erected thereon & known as rosthwaite farm undermill beck windermore south lakeland cumbria. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Wlliams & Glyn's Bank Limited.
    Transazioni
    • 12 giu 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0