ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED

ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàORBITAL MAILING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01096030
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    • Attività di imballaggio (82920) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MACDONALD MAILING LIMITED07 ott 200307 ott 2003
    ANNE MACDONALD ASSOCIATES LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    HALLIGAN MARKETING LIMITED14 feb 197314 feb 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 010960300005 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 010960300006 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Seconda presentazione per la nomina di Mr Gregory John Michael come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Iscrizione dell'ipoteca 010960300006, creata il 28 mar 2019

    26 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Debenture 04/09/2018
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 010960300005, creata il 04 set 2018

    63 pagineMR01

    Cessazione della carica di un segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Francis Alexander Geddes come segretario in data 04 set 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Greggory John Michael come amministratore in data 04 set 2018

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    09 mag 2019Clarification A SECOND FILED AP01 WAS REGISTERED ON 09/05/2019

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 2SF a Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG in data 11 set 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Cassie come amministratore in data 04 set 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Orbital Marketing Services Group Limited come persona con controllo significativo il 02 gen 2018

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Forsyth Rutherford Black come amministratore in data 05 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Stephen Cassie come amministratore in data 05 ago 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2016

    Stato del capitale al 21 giu 2016

    • Capitale: GBP 799
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCOURT, Paul Raymond Patrick
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Amministratore
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    ScotlandBritish183278190001
    MICHAEL, Gregory John
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Amministratore
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    United KingdomBritish250488740001
    GEDDES, John Francis Alexander
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    Segretario
    Twelvetrees Crescent
    E3 3JG London
    Unit E, Twelvetrees Business Park
    England
    188527670001
    HAYDON, Dawn
    4 Sunset Close
    CT5 4PQ Whitstable
    Kent
    Segretario
    4 Sunset Close
    CT5 4PQ Whitstable
    Kent
    British84162040001
    POPE, Bernard John
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    Segretario
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    British114493670001
    STIMPSON, Sydney Oswald George
    Valley Farmhouse
    Stalisfield
    ME13 0HW Faversham
    Kent
    Segretario
    Valley Farmhouse
    Stalisfield
    ME13 0HW Faversham
    Kent
    British8459760001
    TIPPING, Barry Peter
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    Segretario
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    British91218400003
    TURNBULL, David Alistair
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Segretario
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    British174872230001
    WINDING, Susan Caroline
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Segretario
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    British40699270003
    BARRETT, John Robert
    16 Chanctonbury Chase The Grange
    Seasalter
    CT5 4SS Whitstable
    Kent
    Amministratore
    16 Chanctonbury Chase The Grange
    Seasalter
    CT5 4SS Whitstable
    Kent
    British29240410003
    BLACK, Forsyth Rutherford
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish188546240002
    BLAND, Catherine Mary
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Amministratore
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    ScotlandBritish153744340002
    BURFORD, Diana Pauline
    Spelders Hill
    Brook
    TN25 5PB Ashford
    Spelders Hill Farm
    Kent
    Amministratore
    Spelders Hill
    Brook
    TN25 5PB Ashford
    Spelders Hill Farm
    Kent
    EnglandBritish35997610001
    BURFORD, Ronald Albert
    Stone Street
    Westenhanger
    CT21 4HS Hythe
    Lyveden
    Kent
    Amministratore
    Stone Street
    Westenhanger
    CT21 4HS Hythe
    Lyveden
    Kent
    EnglandBritish35997620001
    CASSIE, Mark Stephen
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    Amministratore
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    ScotlandBritish161586010001
    KLEINMAN, Andre John Leonard
    Cheriton Road
    CT19 5JR Folkestone
    138
    Kent
    Amministratore
    Cheriton Road
    CT19 5JR Folkestone
    138
    Kent
    EnglandBritish94816660001
    MARKLAND, Paul
    Rydlings
    Bossingham Road Stelling Minnis
    CT4 6AZ Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Rydlings
    Bossingham Road Stelling Minnis
    CT4 6AZ Canterbury
    Kent
    United KingdomBritish15225430003
    MCINTOSH, David Dennis
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    Amministratore
    New Square
    TW14 8HA Bedfont Lakes
    4
    Middlesex
    ScotlandBritish85826730002
    MOORE, Phillip John
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    Amministratore
    171 Dover Road
    Walmer
    CT14 7NB Deal
    Kent
    EnglandBritish100657710001
    NANGLE, Thomas Joseph
    1 Croft Walk
    EN10 6LD Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Croft Walk
    EN10 6LD Broxbourne
    Hertfordshire
    EnglandBritish92232470001
    POPE, Bernard John
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    Amministratore
    3 Kingston Close
    River, River
    CT17 0NQ Dover
    Kent
    EnglandBritish114493670001
    TIPPING, Barry Peter
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    Amministratore
    Acorn Close
    Hawkinge
    CT18 7QA Folkestone
    5
    Kent
    EnglandBritish91218400003
    WINDING, Julian
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Amministratore
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish8459770004
    WINDING, Susan Caroline
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    Amministratore
    Waterford House
    Joy Lane
    CT5 4LS Whitstable
    Kent
    British40699270003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    06 apr 2016
    World Business Centre Heathrow, Newall Road
    London Heathrow Airport
    TW6 2SF Hounslow
    2
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01471252
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 mar 2019
    Consegnato il 05 apr 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (As Senior Security Agent)
    Transazioni
    • 05 apr 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 set 2018
    Consegnato il 17 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land on the south side of bluestem road, ransomes europark, ipswich and registered under title number SK181952. For further details of property being charged please see schedule 3 attached to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP
    Transazioni
    • 17 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 set 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Michelsons tie factory staplehurst road sittingbourne kent t/nos.K394584 and K109491. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 ott 1991
    Consegnato il 04 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 1990
    Consegnato il 23 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 saxon road faversham kent t/n - K639384 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 feb 1980
    Consegnato il 29 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1, saxon road, faversham, kent. Title no. K154695.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0