ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01096030 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
- Attività di imballaggio (82920) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent E3 3JG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MACDONALD MAILING LIMITED | 07 ott 2003 | 07 ott 2003 |
| ANNE MACDONALD ASSOCIATES LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| HALLIGAN MARKETING LIMITED | 14 feb 1973 | 14 feb 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 010960300005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 010960300006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Seconda presentazione per la nomina di Mr Gregory John Michael come amministratore | 6 pagine | RP04AP01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 010960300006, creata il 28 mar 2019 | 26 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 21 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 010960300005, creata il 04 set 2018 | 63 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di un segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John Francis Alexander Geddes come segretario in data 04 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Greggory John Michael come amministratore in data 04 set 2018 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 2SF a Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG in data 11 set 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Cassie come amministratore in data 04 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Orbital Marketing Services Group Limited come persona con controllo significativo il 02 gen 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Forsyth Rutherford Black come amministratore in data 05 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark Stephen Cassie come amministratore in data 05 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCOURT, Paul Raymond Patrick | Amministratore | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | Scotland | British | 183278190001 | |||||
| MICHAEL, Gregory John | Amministratore | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | United Kingdom | British | 250488740001 | |||||
| GEDDES, John Francis Alexander | Segretario | Twelvetrees Crescent E3 3JG London Unit E, Twelvetrees Business Park England | 188527670001 | |||||||
| HAYDON, Dawn | Segretario | 4 Sunset Close CT5 4PQ Whitstable Kent | British | 84162040001 | ||||||
| POPE, Bernard John | Segretario | 3 Kingston Close River, River CT17 0NQ Dover Kent | British | 114493670001 | ||||||
| STIMPSON, Sydney Oswald George | Segretario | Valley Farmhouse Stalisfield ME13 0HW Faversham Kent | British | 8459760001 | ||||||
| TIPPING, Barry Peter | Segretario | Acorn Close Hawkinge CT18 7QA Folkestone 5 Kent | British | 91218400003 | ||||||
| TURNBULL, David Alistair | Segretario | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | British | 174872230001 | ||||||
| WINDING, Susan Caroline | Segretario | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | British | 40699270003 | ||||||
| BARRETT, John Robert | Amministratore | 16 Chanctonbury Chase The Grange Seasalter CT5 4SS Whitstable Kent | British | 29240410003 | ||||||
| BLACK, Forsyth Rutherford | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 188546240002 | |||||
| BLAND, Catherine Mary | Amministratore | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | Scotland | British | 153744340002 | |||||
| BURFORD, Diana Pauline | Amministratore | Spelders Hill Brook TN25 5PB Ashford Spelders Hill Farm Kent | England | British | 35997610001 | |||||
| BURFORD, Ronald Albert | Amministratore | Stone Street Westenhanger CT21 4HS Hythe Lyveden Kent | England | British | 35997620001 | |||||
| CASSIE, Mark Stephen | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 | Scotland | British | 161586010001 | |||||
| KLEINMAN, Andre John Leonard | Amministratore | Cheriton Road CT19 5JR Folkestone 138 Kent | England | British | 94816660001 | |||||
| MARKLAND, Paul | Amministratore | Rydlings Bossingham Road Stelling Minnis CT4 6AZ Canterbury Kent | United Kingdom | British | 15225430003 | |||||
| MCINTOSH, David Dennis | Amministratore | New Square TW14 8HA Bedfont Lakes 4 Middlesex | Scotland | British | 85826730002 | |||||
| MOORE, Phillip John | Amministratore | 171 Dover Road Walmer CT14 7NB Deal Kent | England | British | 100657710001 | |||||
| NANGLE, Thomas Joseph | Amministratore | 1 Croft Walk EN10 6LD Broxbourne Hertfordshire | England | British | 92232470001 | |||||
| POPE, Bernard John | Amministratore | 3 Kingston Close River, River CT17 0NQ Dover Kent | England | British | 114493670001 | |||||
| TIPPING, Barry Peter | Amministratore | Acorn Close Hawkinge CT18 7QA Folkestone 5 Kent | England | British | 91218400003 | |||||
| WINDING, Julian | Amministratore | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | United Kingdom | British | 8459770004 | |||||
| WINDING, Susan Caroline | Amministratore | Waterford House Joy Lane CT5 4LS Whitstable Kent | British | 40699270003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzies Response Limited | 06 apr 2016 | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ORBITAL MAILING SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 28 mar 2019 Consegnato il 05 apr 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 set 2018 Consegnato il 17 set 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Land on the south side of bluestem road, ransomes europark, ipswich and registered under title number SK181952. For further details of property being charged please see schedule 3 attached to the instrument. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 set 2001 Consegnato il 13 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Michelsons tie factory staplehurst road sittingbourne kent t/nos.K394584 and K109491. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 ott 1991 Consegnato il 04 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 14 ago 1990 Consegnato il 23 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1 saxon road faversham kent t/n - K639384 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 22 feb 1980 Consegnato il 29 feb 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1, saxon road, faversham, kent. Title no. K154695.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0