WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED

WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWYN UK DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01100599
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (4550) /

    Dove si trova WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    101 Wigmore Street
    W1U 1QU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARCADIAN U.K. DEVELOPMENTS LIMITED21 dic 199221 dic 1992
    WESTMINSTER & COUNTRY PROPERTIES (KING STREET) LIMITED08 mar 197308 mar 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution ;- "Books, Records,etc.
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2012

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2012

    Stato del capitale al 27 mar 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Change of registered office address 06/03/2012
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyndham International 65 Duke Street London W1K 5AJ in data 23 mar 2012

    2 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Pegler il 28 set 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STOLL, Peter Huston
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    Segretario
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    American,107030970003
    ALBA, Glenn Emilio
    364 Stevens Avenue
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    07450
    Usa
    Amministratore
    364 Stevens Avenue
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    07450
    Usa
    American112489010001
    PEGLER, Michael John
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    EnglandBritish113065790004
    STOLL, Peter Huston
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    Amministratore
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    United KingdomAmerican,107030970003
    BLUM, Edward Jesse
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    Segretario
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    American65674420003
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    Segretario
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    BRIGHT, Neil Irvine
    89 Nelson Road
    Wimbledon
    SW19 1HU London
    Segretario
    89 Nelson Road
    Wimbledon
    SW19 1HU London
    British9736460001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    BLOUNT, Byron Gilbert
    5 Madrigal
    San Clemente
    Calafornia
    92673
    Usa
    Amministratore
    5 Madrigal
    San Clemente
    Calafornia
    92673
    Usa
    American112490800001
    BLUM, Edward Jesse
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    Amministratore
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    American65674420003
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    Amministratore
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    American65674380001
    BOS, Patrick Albert
    5 St Michaels Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 St Michaels Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37135270001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Amministratore
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    British38255700004
    CAMERON, John Douglas
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    Amministratore
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    United KingdomBritish73541250001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    Amministratore
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66262660001
    HULLS, Michael Stanley
    32 Hatchgate Gardens
    SL1 8DD Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Hatchgate Gardens
    SL1 8DD Burnham
    Buckinghamshire
    British67081650001
    PARKES, David Brian
    28 Eaton Square
    SW1W 9DF London
    Amministratore
    28 Eaton Square
    SW1W 9DF London
    British80771510001
    PRIESTLEY, Jeremy Robert
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Amministratore
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    EnglandBritish766060001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    Amministratore
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66261390001
    SOLLS, Mark Alan
    5314 Harbor Town Drive
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    Amministratore
    5314 Harbor Town Drive
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    American85742190001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    UPTON, Christopher George
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    EnglandBritish103753080001

    WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 mag 1996
    Consegnato il 11 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited the Banks (The "Security Trustee")for Itself and as Agent and Trustee on Behalf Of
    Transazioni
    • 11 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 1994
    Consegnato il 08 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 set 1994
    Consegnato il 27 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 27 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 26 ago 1994
    Consegnato il 06 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 06 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security registered in scotland
    Creato il 08 ago 1990
    Consegnato il 16 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from westminster and country properties PLC to the chargee under the personal bond.
    Brevi particolari
    278 west george street and 160 pitt street, glasgow strathclyde title no gla 33007.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security registred in scotland
    Creato il 23 nov 1989
    Consegnato il 29 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from westminster & country properties PLC to the chargee in terms of a personal bond dated 9/11/89
    Brevi particolari
    110/114 bath street, glasgow title no: gla 57899.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 19 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 12/9/89
    Brevi particolari
    All and whole a mixed development of retail and residential premises on ground floors k/a 80-102 channel street, galashiels and 71-87 overhaugh street galasheils in the burgh of galashiels at county of selkirk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Creato il 22 mar 1989
    Consegnato il 10 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Anniesland industrial estate netherton road glasgow title no's gla 18678, gla 51825.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 07 lug 1988
    Consegnato il 11 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37 high street, kings lynn norfolk. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 1988
    Consegnato il 07 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    2/3 the highway, station road, beaconsfield.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 27 mag 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from westminster country properties PLC in terms of a personal bond dated 25/5/88 to the chargee
    Brevi particolari
    All & whole that area or piece of ground containing 611 17/36 sq yds or thereby together with the whole buildings erected thereon k/a 226 west george street, glasgow and 114 to 118 west campbell street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 18 gen 1988
    Consegnato il 19 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3/19 high street barkingside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Creato il 31 dic 1987
    Consegnato il 13 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 29/12/87
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 2,072 yds approx at the junction of west george street and pitt street glasgow known as st judes house 278 west george street & 160 pitt street (including the bridge connecting st judes house with 21 blythswood square).
    Persone aventi diritto
    • Lilley Development Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Creato il 31 dic 1987
    Consegnato il 11 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from westminster and country properties in terms of a personal bond dated 29/12/87 to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that area of ground extending to 2,272 sq yd lying at the junction of west george street and pitt street glasgow together with st judes house 278 west george street and 160 pitt street and car parking spaces to the buildings.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Creato il 31 dic 1987
    Consegnato il 11 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from westminster & country properties PLC in terms of a personal bond dated 29/12/87 to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that area of ground of 1289 sq yds on the north side of west george street and west side of blythswood square glasgow together with the buildings at 21 blythwood square & 268 west george street.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 1987
    Consegnato il 24 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The windsor public house silver street, bedford, bedfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over contract
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 03 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that benefit of agreement for sale purchase and development at jetty marsh road newton abbot devon dated 16/9/86 between westminster and country properties (king street) limited and westminster and country properties PLC and commercial union assurance company PLC.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 set 1986
    Consegnato il 22 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south-west side of marsh lane southampton. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1986
    Consegnato il 03 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    16/18, rose street, workingham, berkshire land forming part of title no: bk 126699.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 1986
    Consegnato il 25 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the and/or westminster and country properties PLC company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land formerly known as 1-15 (odd nos inclusive) abbot street & 36, 38 & 40 kingsland high street and the amherst cinema kingsland high street, london borough of the hackney title nos ln 34159 & ln 21045.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 mag 1986
    Consegnato il 20 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land situate on the south west side of market street falmouth cornwall together with buildings erected thereon or some part thereof k/a ground cinema market street falmouth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 06 feb 1986
    Consegnato il 20 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the galleon restaurant 7, victoria square, truro, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 05 feb 1986
    Consegnato il 10 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 32/33 high street, lymington, hampshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1986
    Consegnato il 06 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    38/40, westgate street gloucester gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1985
    Consegnato il 24 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    "Getty marsh" getty marsh road newton abbot devon, and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2012Inizio della liquidazione
    21 mag 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0