MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOTHERCARE TOYS 3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01103663
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EARLY LEARNING LIMITED23 mar 197323 mar 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ott 2023

    17 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Westside 1 London Road Hemel Hempstead HP3 9TD United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 07 nov 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 ott 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 25 apr 2022

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 6

    2 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 011036630007

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 011036630008

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 011036630009

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 011036630010

    1 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011036630007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011036630008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011036630009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011036630010 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2021

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MEDINI, Lynne Samatha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    British167184730001
    COOK, Andrew
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Amministratore
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishAccountant266409860001
    MEDINI, Lynne Samantha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Amministratore
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishChartered Secretary70989770003
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Segretario
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    British44142970001
    BRAMALL, Helen Mary
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary59695650001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Segretario
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Segretario
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    British116097830001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Segretario
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Segretario
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Segretario
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    UsFinance Director97940820001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    Segretario
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    British134102250001
    J M SECRETARIES LIMITED
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    Segretario
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    61308040001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Amministratore
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Amministratore
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ASHBY, Timothy John
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Great BritainBritishGeneral Counsel162876770001
    ATWAL, Harminder Singh
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant167976490001
    BENNETT, James Douglas Scott
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Amministratore
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    BritishCompany Director365550003
    BLACK, Robert
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    Amministratore
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    BritishCompany Director50558240001
    BOYDELL, Joanna
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118883430001
    CLARK, Darren Wayne
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant212137270001
    CRANKSHAW, Andrew Ernest
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    Amministratore
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    United KingdomBritishCompany Director28581470002
    DUNCAN, Robert Ian
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    BritishCompany Director59423840001
    ELLIS, Peter Malcolm
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director55540630003
    FRANCE, Michael Bernard Anthony
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director141561430001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director157815820001
    HOMER, Kirsty Rowena
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHr Director235620910001
    JENKINSON, Dermot Julian
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    Amministratore
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritishCompany Director681840002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Amministratore
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    EnglandBritishFinance Director116097830001
    JUCKES, Daniel
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    Amministratore
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant255996600001
    MACKAY, David James
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    Amministratore
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    ScotlandBritishCompany Director681850002
    MARTIN, Alan
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant188726960001
    NEEDHAM, Phillip Geoffrey
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58920590001
    NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    BritishCompany Director21482560001
    RAINER, Michael James
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    Amministratore
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    United KingdomBritishChartered Accounta14442650003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    06 apr 2016
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00102194
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 mag 2018
    Consegnato il 23 mag 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 dic 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 mag 2018
    Consegnato il 23 mag 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2017
    Consegnato il 12 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 12 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2017
    Consegnato il 12 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 12 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 dic 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share mortgage
    Creato il 18 mag 2012
    Consegnato il 07 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares being 100 ordinary share of hk$1 each in the issued share capital of mgsl, constituting the entire issued share capital of mgsl, comprising of 1 ordinary share being held by the chargor and 99 ordinary shares being held by early learning centre limited.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 26 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 06 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 ago 2006
    Consegnato il 30 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    87 high street bedford t/no BD103103 3 hounds hill centre blackpool t/no LA501867 31 lion yard cambridge t/no CB58716 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • D.C. Thomson & Company Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 15 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    87 high street bedford t/n BD103103, 3 hounds hill centre t/n LA501867, 31 lionyard cambridge t/n CB58716 for details of further properties charged please refe. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    Transazioni
    • 15 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any holder of payment in kind notes pursuant to the investment agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations which are as at 28 september 2001 or may at any time thereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever to the bank by any group company on any account whatsoever under the terms of the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 ott 2022Inizio della liquidazione
    17 mag 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0