ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED

ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01105312
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8-10 Moorgate Moorgate
    EC2R 6DA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    APPLEYARD FINANCE HOLDINGS LIMITED30 mar 197330 mar 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Adrian Neil Marsh come amministratore in data 26 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gerald Roderick Munro Walker come amministratore in data 22 giu 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 60 London Wall London EC2M 5TQ England a 8-10 Moorgate Moorgate London EC2R 6DA in data 08 giu 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 3,700,000
    SH01

    Cessazione della carica di Brian James Mcdougall come segretario in data 01 feb 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 60 High Street Redhill Surrey RH1 1NY a 60 London Wall London EC2M 5TQ in data 28 gen 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 01 mag 2014

    16 pagineRP04

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 01 mag 2013

    16 pagineRP04

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 01 mag 2012

    16 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2015

    Stato del capitale al 07 mag 2015

    • Capitale: GBP 3,700,000
    SH01

    Nomina di Mr Simon Peter Berg come amministratore in data 02 gen 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gerald Roderick Munro Walker come amministratore in data 02 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hein Jacobus Pieter Willem Brand come amministratore in data 02 gen 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2014

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 3,700,000
    SH01
    Note
    DataNota
    11 giu 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 11/06/2015

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BERG, Simon Peter
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    EnglandGermanBanker193895870001
    MARSH, Adrian Neil
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    EnglandBritishSolicitor57820580001
    MCDOUGALL, Brian James
    London Wall
    EC2M 5TQ London
    60
    England
    Segretario
    London Wall
    EC2M 5TQ London
    60
    England
    177936640001
    MITCHESON, David
    3 Parkstone
    Bradley
    HD2 1QL Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Parkstone
    Bradley
    HD2 1QL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director114514720001
    PRIDMORE, Ross John
    22 Oaken Grove
    SL6 6HQ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    22 Oaken Grove
    SL6 6HQ Maidenhead
    Berkshire
    British25904600002
    TAPSON, Andrew Michael Ebsworthy
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    164035730001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Segretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Segretario
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director20102900001
    AXAM, Christopher Stanley
    5 Bowenhurst Gardens
    Church Crookham
    GU13 0NB Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    5 Bowenhurst Gardens
    Church Crookham
    GU13 0NB Fleet
    Hampshire
    BritishRisk Manager28513550001
    BERGSTEIN, Karin Trees Veerle
    T Prieel 3
    Oudeilied Ad Amstel
    1191 Pa
    Netherlands
    Amministratore
    T Prieel 3
    Oudeilied Ad Amstel
    1191 Pa
    Netherlands
    DutchManager114608900001
    BRADLEY, Eamon
    18 Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    18 Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director53412070002
    BRAND, Hein Jacobus Pieter Willem
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCeo165629010001
    CALLENDER, John Dalrymple
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishBanker2444200005
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishFinance Director1188140001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    BritishChartered Accountant5529800001
    FOSTER, Steven Gareth
    Heathgrove Barn
    Heath Road Sapiston
    IP31 1RY Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Heathgrove Barn
    Heath Road Sapiston
    IP31 1RY Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishDirector74811670001
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Amministratore
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    BritishFinance Director75730290003
    MAUDE, Alan Stuart
    Holly Lodge Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Holly Lodge Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director507960007
    MOSELEY, Ian Angus
    165 Mancroft Road
    Aley Green
    LU1 4DR Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    165 Mancroft Road
    Aley Green
    LU1 4DR Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishBusiness Risk Partner88673900001
    PRESLEY, David
    2 Shearman Road
    Hadleigh
    IP7 5JW Ipswich
    Amministratore
    2 Shearman Road
    Hadleigh
    IP7 5JW Ipswich
    EnglandBritishDirector124899580002
    TILBROOK, Ian Charles
    10 Chertsey Road
    GU24 8NB Chobham
    Surrey
    Amministratore
    10 Chertsey Road
    GU24 8NB Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishGeneral Manager78282000001
    TOMS, Robert Peter
    Kees Chalkhouse Green Road
    RG4 9AU Kidmore End
    Berkshire
    Amministratore
    Kees Chalkhouse Green Road
    RG4 9AU Kidmore End
    Berkshire
    United KingdomBritish,IrishCompany Director59543150001
    TOPPER, Hendricus Petrus Maria
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    RH1 1NY Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCfo79689020001
    WALKER, Gerald Roderick Munro
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    EnglandBritishBanker58557490002
    WARD, Peter Terry
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    Amministratore
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    EnglandBritishDirector55900930001
    WATERSON, Raymond George
    Heatherwold House
    Churt Road
    GU26 6HX Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    Heatherwold House
    Churt Road
    GU26 6HX Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishBanker65789830001
    WATERSON, Raymond George
    Heatherwold House
    Churt Road
    GU26 6HX Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    Heatherwold House
    Churt Road
    GU26 6HX Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishBanker65789830001
    WELSH, David Charles
    2 The Mallards
    GU16 8PB Frimley
    Surrey
    Amministratore
    2 The Mallards
    GU16 8PB Frimley
    Surrey
    BritishRisk Director6886650002
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChairman & Chief Executive57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    CanadianFinance Director51303670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    06 apr 2016
    Moorgate
    EC2R 6DA London
    8-10 Moorgate
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02453767
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ING CAR (FOUR) HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 22 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 mag 1992
    Consegnato il 01 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    SE 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 06 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets and rights present and future including goodwill bookdebts uncalled capital all rights title and interes in all hiring agreements (if any) in respect of motor vehicles and all chattels comprised there and all benefit of all securities guarantees and indemnities (please refer to doc M9/7JUL/ln for fulldetails).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Industrial Fiance Limited
    Transazioni
    • 06 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 lug 1982
    Consegnato il 15 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital all right title & interst in all hiring agreements (if any) in rejects of motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 15 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 12 mar 1980
    Consegnato il 19 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over (colleatively called the assets). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Forward Leasing Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 12 mar 1980
    Consegnato il 19 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over (collectively called the assets). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Montague Leasing Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0